ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED

ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01301462
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    • Activités des agents et courtiers d'assurance (66220) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    71 Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BARFERN LIMITED07 mars 197707 mars 1977

    Quels sont les derniers comptes de ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Statuts

    28 pagesMA

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 avr. 2023

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 013014620018

    1 pagesMR05

    Cessation de la nomination de Sian Woods en tant que secrétaire le 31 mars 2023

    1 pagesTM02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 013014620018, créée le 21 déc. 2022

    32 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Neil Martin Clayton en tant que directeur le 30 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Sian Woods en tant que secrétaire le 07 déc. 2022

    2 pagesAP03

    Statuts

    2 pagesMA

    Statuts

    28 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2021 au 30 juin 2022

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew Edward Behrends en tant que directeur le 01 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter John Burton en tant que secrétaire le 22 mai 2019

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Katherine Anne Cross en tant qu'administrateur le 12 févr. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROSS, Katherine Anne
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant177177850002
    BURTON, Peter John
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    203637140001
    EDWARDS, Richard David Lewis
    Grove Cottage 22 Epping Road
    Toot Hill
    CM5 9SQ Ongar
    Essex
    Secrétaire
    Grove Cottage 22 Epping Road
    Toot Hill
    CM5 9SQ Ongar
    Essex
    BritishChartered Accountant41728290001
    FRANCE, Alexander Ian Robert
    12 Bucklands
    Thorpe Bay
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    12 Bucklands
    Thorpe Bay
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    British32411230001
    FRANKLIN, David John
    18 Lyveden Road
    Blackheath
    SE3 London
    Secrétaire
    18 Lyveden Road
    Blackheath
    SE3 London
    British10558900002
    KNOBLAUCH, Franz Josef
    47 Skyline Plaza
    80 Commercial Road
    E1 1NY London
    Secrétaire
    47 Skyline Plaza
    80 Commercial Road
    E1 1NY London
    IrishCompany Director59397660004
    WOODS, Sian
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    303083770001
    DQ FINANCIAL CONSULTING LIMITED
    c/o Joe Knoblauch
    80 Commercial Road
    E1 1NY London
    47 Skyline Plaza
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Joe Knoblauch
    80 Commercial Road
    E1 1NY London
    47 Skyline Plaza
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7342780
    154595910001
    BARNACOTT, Nicholas William
    52 Vermeer Court
    Rembrandt Close
    E14 3XA London
    Administrateur
    52 Vermeer Court
    Rembrandt Close
    E14 3XA London
    BritishDirector67310080002
    BARTON, Nigel Anthony
    Church Farm
    Priors Dean
    GU32 1BS Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Church Farm
    Priors Dean
    GU32 1BS Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director17934750002
    BEHRENDS, Andrew Edward
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    United StatesAmericanAccountant244419050001
    CHAPMAN, Antony Docwra
    America Square
    EC3N 2LU London
    2
    Administrateur
    America Square
    EC3N 2LU London
    2
    United KingdomBritishGlobal Broking Director193035670002
    CLAYTON, Neil Martin
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    United KingdomBritishInsurance Broker99557160001
    CLAYTON, Neil Martin
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Administrateur
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    United KingdomBritishInsurance Broker99557160001
    CLOUGH, Claire Victoria
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant204772630002
    DAVIES, James Barclay Tudor
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Administrateur
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    United KingdomBritishRisk Manager89011960004
    EDWARDS, Richard David Lewis
    Grove Cottage 22 Epping Road
    Toot Hill
    CM5 9SQ Ongar
    Essex
    Administrateur
    Grove Cottage 22 Epping Road
    Toot Hill
    CM5 9SQ Ongar
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant41728290001
    ELLIOTT, Graham Andrew
    Colhook Common
    GU28 9LE Petworth
    Old Colhook Farm House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Colhook Common
    GU28 9LE Petworth
    Old Colhook Farm House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135539130001
    FRANCE, Alaxander Ian Robert
    America Square
    EC3N 2LU London
    2
    Administrateur
    America Square
    EC3N 2LU London
    2
    United KingdomBritishInsurance Broker168089810001
    FRANCE, Alexander Ian Robert
    8 Thorpe Hall Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3AU Southend On Sea
    Administrateur
    8 Thorpe Hall Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3AU Southend On Sea
    EnglandBritishInsurance Broker32411230002
    FRANKLIN, David John
    18 Lyveden Road
    Blackheath
    SE3 London
    Administrateur
    18 Lyveden Road
    Blackheath
    SE3 London
    BritishAccountant10558900002
    FULLER, James William
    33 Harbour Exchange Square
    London
    E14 9GG
    Administrateur
    33 Harbour Exchange Square
    London
    E14 9GG
    EnglandBritishDirector156741170001
    GOEBBELS, Martin John
    24 Burnthwaite Road
    SW6 5BE London
    Administrateur
    24 Burnthwaite Road
    SW6 5BE London
    BritishInsurance Broker31254310002
    HENRY, Neil
    33 Harbour Exchange Square
    E14 9GG London
    Robertson Taylor Insurance Brokers Ltd
    United Kingdom
    Administrateur
    33 Harbour Exchange Square
    E14 9GG London
    Robertson Taylor Insurance Brokers Ltd
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant124626840001
    HUMPHREYS, Toby James
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Administrateur
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    EnglandBritishInsurance Broker73028700001
    HUNNISETT, Joseph Charlton
    Knox Insurance Brokers Limited
    705 Cassells Street
    North Bay
    Ontario P1b 4a3
    Canada
    Administrateur
    Knox Insurance Brokers Limited
    705 Cassells Street
    North Bay
    Ontario P1b 4a3
    Canada
    CanadaCanadianChartered Accountant164637770001
    KNOX, Bruce Birmingham
    Knox Insurance Brokers Limited
    705 Cassells Street
    North Bay
    Ontario P1b 4a3
    Canada
    Administrateur
    Knox Insurance Brokers Limited
    705 Cassells Street
    North Bay
    Ontario P1b 4a3
    Canada
    CanadaCanadianInsurance Broker164637720001
    MARSHALL, Leslie James
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Administrateur
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    EnglandBritishAccountant22439710004
    MOSELEY, Susan
    33 Harbour Exchange Square
    London
    E14 9GG
    Administrateur
    33 Harbour Exchange Square
    London
    E14 9GG
    United KingdomBritishDirector156740200001
    PETTIFOR, Ian
    Chelwood Close
    CR5 3EY Coulsdon
    6
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Chelwood Close
    CR5 3EY Coulsdon
    6
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector44290380002
    ROBERTSON, William Wardell
    1 Tyrawley Road
    SW6 4QG London
    Administrateur
    1 Tyrawley Road
    SW6 4QG London
    BritishCompany Director28174900002
    SANDAU, Roger
    9974 Westwanda Dr
    Beverley Hills
    California 90210
    Usa
    Administrateur
    9974 Westwanda Dr
    Beverley Hills
    California 90210
    Usa
    UsaAttorney86736740001
    SILCOCK, John
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Administrateur
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    EnglandBritishInsurance Broker66571260001
    SILCOCK, John
    47 Sunningvale Avenue
    Biggin Hill
    TN16 3BX Westerham
    Kent
    Administrateur
    47 Sunningvale Avenue
    Biggin Hill
    TN16 3BX Westerham
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker66571260001
    SUTTON, John David
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Administrateur
    c/o Integro Insurance Brokers Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    EnglandBritishInsurance Broker40087870007

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Integro Insurance Brokers Holdings Ltd
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    04 juil. 2017
    Fenchurch Street
    EC3M 4BS London
    71
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom Companies Register
    Numéro d'enregistrement04016527
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Rtib Holdings Ltd
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    06 avr. 2016
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom Companies Register
    Numéro d'enregistrement03634528
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 déc. 2022
    Livré le 03 janv. 2023
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Global Loan Agency Services Australia Nominees Pty Limited Acn 608 945 008
    Transactions
    • 03 janv. 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 avr. 2023L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 16 nov. 2012
    Livré le 24 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 24 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 25 juin 2003
    Livré le 10 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to: all pledged shares; all dividends and interest in the pledged shares; all collateral, liens and security interests; all other security, money or other property; and all other rights with respect to the foregoing collateral.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 11 juin 2003
    Livré le 16 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and rtib holdings limited to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Own account assignment of life policies
    Créé le 11 juin 2003
    Livré le 16 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policies and all amounts that are to be paid under them and any amount to be paid to the company on cancellation of either policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 23 january 1991(the "principal deed"))
    Créé le 08 déc. 1999
    Livré le 11 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by the chargee its delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed in or about the exercise of the powers contained in the security and trust deed (as modified) or otherwise in relation thereto including all remuneration payable to any such receiver and the payment of all debts and obligations for the time being due owing or incurred whether actually or contingently by the company in respect of insurance transactions
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company (and all assets which would be approved).
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's (A Statutory Corporation)(as Trustee for the Creditors for the Time Being of the Company in Respect of Insurance Transactions)
    Transactions
    • 11 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and total permanent disability policies in the name of david franklin in the sum of £500,000 effected in lutine policy no T870189 and £500,000 effected in lloyds of london policy no ASXG31/98 together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and permanent total disability policies in the name of martin john goebbels in the sum of £500,000 effected in lutine policy no T870189 and £500,00 effected in lloyds of london policy no ASXG31/98 together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and permanent total disability policies in the name of john silcock in the sum of £150,000 effected in lutine policy no T870189 £350,000 effected in confidential life policy and £500,000 effected n lloyds of london policy number ASXG31/98 together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and total permanent disability policies in the name of richard edwards in the sum of £500,000 effected in lloyds of london policy no ASXG31/98 and £500,000 effected in confidential life policy together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and total permanent disability policies in the name of ian france in the sum of £500,000 effected in link policy no LX98/1009895H ,£500,000 effected in lutine and 1,000,000 effected in lloyds of london policy no ASXG31/98 together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and total permanent disability policies in the name of william wardell robertson in the sum of £1,000 000 effected in link policy no LX98/1009895H and £1,000.000 effected in lloyds of london policy no pa-10098266 together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and total permanent disability policies in the name of robert alfredtaylor in the sums of £1,400,000 effected in link policy no LX98/1009895H £500,00 effected in lutine policy NT870189 and £1,900,000 effected in lloyds of london policy no PA98-10098266FITS together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Life and total disability policies in the name of nicholas barnacott in the sum of £1,000,000 effected in confidential life policy and £1,000,000 effected in lloyds of london policy no ASXG31/98 together with all claims monies and other benefits derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 24 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1991
    Livré le 20 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    26 southlands road, bromley l/b of bromley t/n sgl 534482.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security and trust deed.
    Créé le 23 janv. 1991
    Livré le 25 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaws (no. 5 of 1988) (please see doc fo r details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's Respect of Insurance Transactions)(As Trustee for the Time Being of the Company In
    Transactions
    • 25 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juin 1989
    Livré le 08 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units C2 & C3, harbour island, isle of dogs, lb of tower hamlets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 25 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ROBERTSON TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 avr. 2023Commencement of winding up
    14 oct. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0