EHRMANNS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEHRMANNS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01302718
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EHRMANNS LIMITED ?

    • (5134) /

    Où se situe EHRMANNS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EHRMANNS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EHRMANNS GROUP LIMITED06 mars 199206 mars 1992
    VINIBERIA LIMITED15 mars 197715 mars 1977

    Quels sont les derniers comptes de EHRMANNS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour EHRMANNS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 12 juil. 2010

    19 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 janv. 2010

    15 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.15B

    4 pages2.16B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    20 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    31 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    19 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    21 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    18 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    19 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    9 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 mars 2004

    19 pagesAA

    legacy

    9 pages363s

    Divers

    Auditors resignation under S394
    1 pagesMISC

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de EHRMANNS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAPMAN, Jonathan Mark
    48 Copthall Gardens
    TW1 4HJ Twickenham
    Secrétaire
    48 Copthall Gardens
    TW1 4HJ Twickenham
    British72246550002
    CAMPBELL, Hugo Argyll
    471 Latimer Road
    W10 6RD London
    Administrateur
    471 Latimer Road
    W10 6RD London
    United KingdomBritish91846300001
    CHAPMAN, Jonathan Mark
    48 Copthall Gardens
    TW1 4HJ Twickenham
    Administrateur
    48 Copthall Gardens
    TW1 4HJ Twickenham
    British72246550002
    DAUTHIEU, Peter Dominic
    San Bruno
    Montealegre
    FOREIGN Jerez De La Frontera
    Cadiz
    Spain
    Administrateur
    San Bruno
    Montealegre
    FOREIGN Jerez De La Frontera
    Cadiz
    Spain
    SpainBritish34096120001
    DAY, Nicholas Rupert
    Birchdown
    Hardenhuish Lane
    SN14 6HS Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Birchdown
    Hardenhuish Lane
    SN14 6HS Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish80181890001
    JARZEBOWSKI, Michael William Wladyslaw
    Cornella
    179 Wycombe Road
    HP16 0HJ Prestwood
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cornella
    179 Wycombe Road
    HP16 0HJ Prestwood
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92250430001
    LAY, Keith Andrew
    25 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    25 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    British92250610001
    BLATT, Jeffrey Malcolm
    44 Woolhampton Way
    IG7 4QJ Chigwell
    Essex
    Secrétaire
    44 Woolhampton Way
    IG7 4QJ Chigwell
    Essex
    British5219450001
    BOUNDY, Charles
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    Secrétaire
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    British61356560002
    JEFFRIES, Anthea Jeannette
    16 Harrington Heights
    Houghton Regis
    LU5 6JU Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    16 Harrington Heights
    Houghton Regis
    LU5 6JU Dunstable
    Bedfordshire
    British37862200001
    JONES, Christopher David
    89 Bredhurst Road
    Wigmore
    ME8 0QT Gillingham
    Kent
    Secrétaire
    89 Bredhurst Road
    Wigmore
    ME8 0QT Gillingham
    Kent
    British33151030001
    VADHER, Ratilal Nanji
    14 Sunbury Avenue
    Mill Hill
    NW7 3SJ London
    Secrétaire
    14 Sunbury Avenue
    Mill Hill
    NW7 3SJ London
    British17043140001
    CITY ROAD REGISTRARS LIMITED
    16-26 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    Secrétaire
    16-26 Banner Street
    EC1Y 8QE London
    36050670001
    BLATT, Jeffrey Malcolm
    44 Woolhampton Way
    IG7 4QJ Chigwell
    Essex
    Administrateur
    44 Woolhampton Way
    IG7 4QJ Chigwell
    Essex
    British5219450001
    CHAMBERLAYNE-MACDONALD, Nigel Donald Peter
    Cranbury Park
    SO21 2HL Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Cranbury Park
    SO21 2HL Winchester
    Hampshire
    British13892840001
    HARRIS, David
    38 Townshend Road
    NW8 6LE London
    Administrateur
    38 Townshend Road
    NW8 6LE London
    British63475020002
    MAGEE, Dermot Joseph
    1 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AP Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    1 Gordon Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AP Eastleigh
    Hampshire
    British24834620001
    PAGE, William Laurence
    Uplands Farm
    Cryers Hill Lane Widmer End
    HP15 6AA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Uplands Farm
    Cryers Hill Lane Widmer End
    HP15 6AA High Wycombe
    Buckinghamshire
    British33151050002

    EHRMANNS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2003
    Livré le 16 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the stockholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Global Vintners Holdings Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Notarial deed for the pledge of shares
    Créé le 28 juin 2000
    Livré le 12 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or ehrmanns holdings limited to the chargee under the credit agreement (as defined)
    Brèves mentions
    The shares: 2000 shares of face value esp 5000 each and any titles rights securities and assets that correspond to the shares or may replace them.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2000
    Livré le 11 mai 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at rear of 16A highbury place greater london l/b of islington - LN212492 ; freehold land to the north west of corsica street greater london l/b of islington - LN232200 : f/h land being 17 highbury place & 29 corsica place greater london l/b of islington - 434758. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit agreement
    Créé le 10 juil. 1996
    Livré le 16 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement and this deed
    Brèves mentions
    The tenant with full title guarantee charged its interest in the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Frogmore Investments Limited
    Transactions
    • 16 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 1991
    Livré le 18 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part 29, corsica street london borough of islington, title no. Ln 23200.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 1991
    Livré le 18 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part 29 corsica street, london borough of islington title no. 434758.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juin 1991
    Livré le 11 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 oct. 1988
    Livré le 21 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 corsica street, london N5. T/nos 434758, ln 232200.
    Personnes ayant droit
    • Banco Hispano Americano Limited
    Transactions
    • 21 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 13 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 mai 1987
    Livré le 18 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Banco Hispano Americano Limited
    Transactions
    • 18 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 19 mai 1983
    Livré le 01 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Banco Urquigo Hispano Americano Limited
    Transactions
    • 01 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 13 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 juin 1982
    Livré le 15 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or ehrmanns wirle shippers limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1982Enregistrement d'une charge

    EHRMANNS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 juil. 2009Administration started
    12 juil. 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Paul David Williams
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0