C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéC.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01303919
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O ATLANTIC PLASTICS LIMITED
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Mid Glamorgan
    Wales
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Atlantic Plastics Ltd Unit H200 Edison Road Hams Hall Coleshill West Midlands B46 1AB* le 17 mars 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 oct. 2013

    État du capital au 15 oct. 2013

    • Capital: GBP 30,000
    SH01

    Nomination de Mr Mark Vernon Hodgens en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Saul Godfrey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Marcus Billman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Ansgar Nonn en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kris Holla en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Marcus Billman en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Oliver Gosemann en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kris Holla en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Oliver Frank Gosemann en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Cessation de la nomination de Jan Van Ooijen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    18 pagesAA

    Nomination de Mr James Fry en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRY, James
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    Secrétaire
    c/o C/O Atlantic Plastics Limited
    Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Coytrahene
    Mid Glamorgan
    Wales
    158470000001
    HODGENS, Mark Vernon
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Coytrahene Close
    Brackla Industrial Estate
    CF31 2AX Bridgend
    Atlantic Plastics Limited
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritish94971440002
    NONN, Ansgar, Dr
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGerman177013380001
    HUNT, Nigel Thomas
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    Secrétaire
    84 Fabis Close
    Walton Park
    DE11 9SN Swadlincote
    Derbyshire
    British39559640001
    MARTIN, Terry
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    Secrétaire
    18 Ashford Crescent
    EN3 7HU Enfield
    Middlesex
    British69720220001
    MATTHEWS, Darren Jon
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    Secrétaire
    60 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Shirley
    West Midlands
    British112391130001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    Secrétaire
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    British57030200002
    BILLMAN, Marcus
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Senefelder Strasse 2
    63110 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    United KingdomSwedish142246880001
    CATT, Nicholas William
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    Administrateur
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    EnglandBritish128624750001
    DAWES, Michael William
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    The Nook
    Alton
    ST10 4BH Stoke On Trent
    Staffordshire
    British21194340001
    DURY, Paul John Edwin
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    45 St Johns Treet
    DE6 1GP Ashbourne
    Derbyshire
    British46194000001
    EDMONDS, David Henry
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    One Carrington House
    Buxton Road
    DE6 1EX Ashbourne
    Derbyshire
    British73468520001
    GODFREY, Saul Gideon
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Charwood Close
    WD7 9LH Shenley
    12
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish103524290001
    GOSEMANN, Oliver Frank
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyGerman167850440001
    HOLLA, Kris
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Senefelder Strasse 2
    63100 Rodgau
    Talis Management Holding Gmbh
    Germany
    GermanyAmerican167994810001
    KING, Stuart Derek
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    68 Wenallt Road
    Rhiwbina
    CF4 6SE Cardiff
    South Glamorgan
    British40173530001
    MACKEY, Damian
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Administrateur
    18 Clinton Road
    CF64 3JD Penarth
    South Glamorgan
    Australian125261330001
    MCKENDRY, Francis James
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    Administrateur
    26/28 Avenue Raymond Poincarre
    FOREIGN Paris
    75116
    France
    FranceBritish124595550001
    NICHOLAS, David Charles
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    British96403410001
    POLINE, Olivier Pierre
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    Administrateur
    30 Allee Du Chateau
    69780 Mioms
    France
    French112391190001
    TURNER, Stanley
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    Administrateur
    The Maples
    The Park
    B79 9DF Elford
    Staffordshire
    EnglandBritish70686150004
    VAN OOIJEN, Jan Roelf
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    Administrateur
    Heeckerenlaan 5
    7531 HW Enschede
    7531 Hw
    Netherlands
    Dutch125281750001
    WALKER, Lesley
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Brookside
    Birch Cross, Marchington
    ST14 8NU Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritish57030200002
    WARD, Marcus Gordon Waddie
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Administrateur
    Rue De Tenbosch 85
    Flat 113
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    British74246040001
    WHELDON, Stephen
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    Administrateur
    11 Ashfield Park
    NE16 4SQ Whickham
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish93126410001
    WILLIAMS, Andrew
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    Administrateur
    79 The Crescent
    WS1 2DA Walsall
    British39210390001

    C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 06 janv. 2000
    Livré le 11 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 20 août 1999
    Livré le 27 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and garage premises and part garage premises on the west side of woodland road swadlincote derbyshire t/no's;-DY3354 DY3355. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 mars 1994
    Livré le 20 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 20 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 oct. 1991
    Livré le 22 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & premises woodland road swadlincote t/no DY3354 & DY3355.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 13 mars 1987
    Livré le 20 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book & other debts now & from time to time due or owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 1982
    Livré le 08 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land & premises k/a 115 and 117 hearthcote road, swadlincote, derbyshire. Title no: dy 82283.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 16 déc. 1977
    Livré le 29 déc. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1977Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0