C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01303919 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o C/O ATLANTIC PLASTICS LIMITED Coytrahene Close Brackla Industrial Estate CF31 2AX Bridgend Mid Glamorgan Wales |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Atlantic Plastics Ltd Unit H200 Edison Road Hams Hall Coleshill West Midlands B46 1AB* le 17 mars 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Mark Vernon Hodgens en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Saul Godfrey en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marcus Billman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Dr Ansgar Nonn en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2012 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kris Holla en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Marcus Billman en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Oliver Gosemann en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kris Holla en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Oliver Frank Gosemann en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2011 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jan Van Ooijen en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 18 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr James Fry en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRY, James | Secrétaire | c/o C/O Atlantic Plastics Limited Close Brackla Industrial Estate CF31 2AX Bridgend Coytrahene Mid Glamorgan Wales | 158470000001 | |||||||
| HODGENS, Mark Vernon | Administrateur | Coytrahene Close Brackla Industrial Estate CF31 2AX Bridgend Atlantic Plastics Limited Mid Glamorgan Wales | England | British | 94971440002 | |||||
| NONN, Ansgar, Dr | Administrateur | Senefelder Strasse 2 63110 Rodgau Talis Management Holding Gmbh Germany | Germany | German | 177013380001 | |||||
| HUNT, Nigel Thomas | Secrétaire | 84 Fabis Close Walton Park DE11 9SN Swadlincote Derbyshire | British | 39559640001 | ||||||
| MARTIN, Terry | Secrétaire | 18 Ashford Crescent EN3 7HU Enfield Middlesex | British | 69720220001 | ||||||
| MATTHEWS, Darren Jon | Secrétaire | 60 Whitemoor Drive Monkspath B90 4UL Shirley West Midlands | British | 112391130001 | ||||||
| WALKER, Lesley | Secrétaire | 5 Brookside Birch Cross, Marchington ST14 8NU Uttoxeter Staffordshire | British | 57030200002 | ||||||
| BILLMAN, Marcus | Administrateur | Senefelder Strasse 2 63110 Rodgau Talis Management Holding Gmbh Germany | United Kingdom | Swedish | 142246880001 | |||||
| CATT, Nicholas William | Administrateur | Farquhar Street SG14 3BP Hertford Little Eaves 6 Hertfordshire | England | British | 128624750001 | |||||
| DAWES, Michael William | Administrateur | The Nook Alton ST10 4BH Stoke On Trent Staffordshire | British | 21194340001 | ||||||
| DURY, Paul John Edwin | Administrateur | 45 St Johns Treet DE6 1GP Ashbourne Derbyshire | British | 46194000001 | ||||||
| EDMONDS, David Henry | Administrateur | One Carrington House Buxton Road DE6 1EX Ashbourne Derbyshire | British | 73468520001 | ||||||
| GODFREY, Saul Gideon | Administrateur | Charwood Close WD7 9LH Shenley 12 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 103524290001 | |||||
| GOSEMANN, Oliver Frank | Administrateur | Senefelder Strasse 2 63100 Rodgau Talis Management Holding Gmbh Germany | Germany | German | 167850440001 | |||||
| HOLLA, Kris | Administrateur | Senefelder Strasse 2 63100 Rodgau Talis Management Holding Gmbh Germany | Germany | American | 167994810001 | |||||
| KING, Stuart Derek | Administrateur | 68 Wenallt Road Rhiwbina CF4 6SE Cardiff South Glamorgan | British | 40173530001 | ||||||
| MACKEY, Damian | Administrateur | 18 Clinton Road CF64 3JD Penarth South Glamorgan | Australian | 125261330001 | ||||||
| MCKENDRY, Francis James | Administrateur | 26/28 Avenue Raymond Poincarre FOREIGN Paris 75116 France | France | British | 124595550001 | |||||
| NICHOLAS, David Charles | Administrateur | Lillingstone House 84 Knowle Wood Road Dorridge B93 8JP Solihull West Midlands | British | 96403410001 | ||||||
| POLINE, Olivier Pierre | Administrateur | 30 Allee Du Chateau 69780 Mioms France | French | 112391190001 | ||||||
| TURNER, Stanley | Administrateur | The Maples The Park B79 9DF Elford Staffordshire | England | British | 70686150004 | |||||
| VAN OOIJEN, Jan Roelf | Administrateur | Heeckerenlaan 5 7531 HW Enschede 7531 Hw Netherlands | Dutch | 125281750001 | ||||||
| WALKER, Lesley | Administrateur | 5 Brookside Birch Cross, Marchington ST14 8NU Uttoxeter Staffordshire | England | British | 57030200002 | |||||
| WARD, Marcus Gordon Waddie | Administrateur | Rue De Tenbosch 85 Flat 113 FOREIGN Brussels 1050 Belgium | British | 74246040001 | ||||||
| WHELDON, Stephen | Administrateur | 11 Ashfield Park NE16 4SQ Whickham Tyne & Wear | United Kingdom | British | 93126410001 | |||||
| WILLIAMS, Andrew | Administrateur | 79 The Crescent WS1 2DA Walsall | British | 39210390001 |
C.I.S. (CAST IRON SERVICES) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 06 janv. 2000 Livré le 11 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 20 août 1999 Livré le 27 août 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land and garage premises and part garage premises on the west side of woodland road swadlincote derbyshire t/no's;-DY3354 DY3355. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 31 mars 1994 Livré le 20 avr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 oct. 1991 Livré le 22 oct. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land & premises woodland road swadlincote t/no DY3354 & DY3355. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 13 mars 1987 Livré le 20 mars 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on all book & other debts now & from time to time due or owing to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 01 oct. 1982 Livré le 08 oct. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Freehold land & premises k/a 115 and 117 hearthcote road, swadlincote, derbyshire. Title no: dy 82283. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 16 déc. 1977 Livré le 29 déc. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0