CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED

CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01315953
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, de boissons et de tabac (46390) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONTINENTAL TEA AND COFFEE SERVICES LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    CONTINENTAL TEA SERVICES LIMITED02 juin 197702 juin 1977

    Quels sont les derniers comptes de CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2022
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 déc. 2022
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 déc. 2022
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 déc. 2021
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Teunis Snoek en tant que directeur le 30 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    32 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    11 pagesAM02

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    4 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    4 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    4 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    47 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de Alexander House 31-39 London Road Sevenoaks Kent TN13 1AR à Centre Block 4th Floor Central Court Knoll Rise Orpington BR6 0JA le 24 août 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    5 pagesAM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2021 au 30 juin 2022

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Teunis Snoek le 15 févr. 2022

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Mr Teunis Snoek en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 févr. 2022

    2 pagesPSC04

    Cessation de la nomination de Gert-Jan Van Den Akker en tant que directeur le 22 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2020

    45 pagesAA

    Inscription de la charge 013159530029, créée le 11 févr. 2021

    46 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2019

    42 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEIGHINGTON, Sara
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    EnglandBritishTreasurer270677700001
    SNOEK, Jamie Oliver
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    EnglandDutchPeanut Trader157991850001
    SNOEK, Nicholas Aarjan
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomBritishProjects Manager270677670001
    BELLWOOD, David Dean
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    BritishChartered Accountant51609320001
    CONNOR, John
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    Secrétaire
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    BritishFinance Director96761630002
    GILBERT, Richard
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    179306850001
    JORDAN, Peter Christopher
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    162435840001
    RHODES, Kevin John
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    189968830001
    THORNTON, Richard
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    BritishCompany Director100268930001
    WEGG, Michael Arthur
    16 Broadview Avenue
    Rainham
    ME8 9DB Gillingham
    Kent
    Secrétaire
    16 Broadview Avenue
    Rainham
    ME8 9DB Gillingham
    Kent
    British2729730001
    BELLWOOD, David Dean
    116 Oakhill Road
    TN13 1NU Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    116 Oakhill Road
    TN13 1NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishNon Exec Director51609320001
    CONNOR, John
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    Administrateur
    Rosslyn
    High Street
    TN5 7AS Tilehurst
    BritishFinance Director96761630002
    GARRETT, Jacqueline Anne
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    GbrBritishManager114777450001
    GILBERT, Richard
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant86461880001
    JORDAN, Peter Christopher
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishFinance Director162435450001
    JOSLING, Jean Winifred
    Little Shelvey London Road
    TN6 2TR Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    Little Shelvey London Road
    TN6 2TR Crowborough
    East Sussex
    BritishCompany Director38338540001
    ROBINSON, Nicholas Courtenay
    75 Timberbank
    Meopham
    DA13 0SN Gravesend
    Kent
    Administrateur
    75 Timberbank
    Meopham
    DA13 0SN Gravesend
    Kent
    EnglandBritishCo Director18191500001
    SCHONLAND, Marc Claude
    2a Dartford Road
    TN13 3TG Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    2a Dartford Road
    TN13 3TG Sevenoaks
    Kent
    South AfricaCommodity Broker42985250001
    SNOEK, Teunis
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Administrateur
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    United KingdomDutchCompany Director83274220007
    THORNTON, Richard
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    Administrateur
    Tree Tops
    Street End Lane Broad Oak
    TN21 8RX Heathfield
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director100268930001
    VAN DEN AKKER, Gert-Jan
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Alexander House
    31-39 London Road
    TN13 1AR Sevenoaks
    Kent
    SwitzerlandDutchConsultant270677960001
    WEGG, Michael Arthur
    16 Broadview Avenue
    Rainham
    ME8 9DB Gillingham
    Kent
    Administrateur
    16 Broadview Avenue
    Rainham
    ME8 9DB Gillingham
    Kent
    BritishCo Director2729730001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Teunis Snoek
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    06 avr. 2016
    Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Centre Block 4th Floor
    Non
    Nationalité: Dutch
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 11 févr. 2021
    Livré le 18 févr. 2021
    En cours
    Brève description
    None.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kimura Commodity Trade Finance Fund Limited
    Transactions
    • 18 févr. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 juil. 2018
    Livré le 12 juil. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kimura Master Fund Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 mars 2014
    Livré le 20 mars 2014
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • British Arab Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 août 2013
    Livré le 09 sept. 2013
    En cours
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • British Arab Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A security assignment
    Créé le 16 janv. 2013
    Livré le 25 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned rights, being - all rights, title, benefits and interests under or in connection with assigned contracts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture deed
    Créé le 05 déc. 2012
    Livré le 06 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deposit agreement
    Créé le 05 déc. 2012
    Livré le 06 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re continenntal trade and commodity services LTD and numbered 01402602 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Memorandum of pledge and hypothecation of goods
    Créé le 28 nov. 2012
    Livré le 07 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any documents and the goods, any monies payable, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 avr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A trade finance security deed
    Créé le 14 juil. 2011
    Livré le 19 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge assigned receivables, all amounts, credits or other assets and the insurances. The pledged goods and the pledged documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Banque Cantonale Vaudoise
    Transactions
    • 19 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 août 2010
    Livré le 06 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security assignment
    Créé le 30 juin 2010
    Livré le 30 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned assets being all the right title benefit and interest in the assigned contracts the receivables and all guarantees indemnities mortgages charges and other security see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 30 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First party charge over credit balances
    Créé le 16 juin 2010
    Livré le 23 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies from time to time held to the credit of the mortgagor by the bank on any current deposit or other account or accounts or under any deposit receipt.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 23 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trade finance security agreement
    Créé le 10 mars 2010
    Livré le 31 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over all the rights, title and interest in and to all moneys, credits or other assets, all policies and contracts of insurance, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas (Suisse) Sa
    Transactions
    • 31 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 janv. 2006
    Livré le 18 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account charge
    Créé le 04 janv. 2006
    Livré le 23 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit and all right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transactions
    • 23 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 janv. 2006
    Livré le 21 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of receivables
    Créé le 04 janv. 2006
    Livré le 20 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights and all money now or in the future due or owing to the company: under any contracts; in respect of any breach of any contract; under any policy of insurance in respect of bank funded goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V London Branch
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Collection account charge
    Créé le 04 août 2003
    Livré le 20 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V. London Branch
    Transactions
    • 20 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    General charge of receivables and contract rights
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 16 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's right title benefits and interest in and to all monies payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Absa Bank Limited
    Transactions
    • 16 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 16 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Absa Bank Limited
    Transactions
    • 16 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 janv. 2003
    Livré le 30 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 30 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of general pledge, hypothecation and charge
    Créé le 28 sept. 2001
    Livré le 05 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    1).All goods and produce delivered into the actual or constructive possession of ing bank N.V. london branch and all goods financed by the bank through documentary credit or other transaction 2). all bills of lading, receipts or other documents relating to the goods described in (1) above and which are delivered into the actual or constructive possession of the bank 3). the proceeds of sale of any of the goods or documents described in (1) or (2) above 4). all contracts entered into by the company with respect to any goods wqhich have been financed by the bank (including all letter of credit guarantees and contracts of insurance opened or issued with respect to such goods).
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 05 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 janv. 1999
    Livré le 09 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "$10,000,000 facility letter" dated 8TH december 1998 between the company (as a borrower) and the bank and the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und-Vereinsbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 09 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General letter of pledge,hypothecation and charge
    Créé le 09 févr. 1998
    Livré le 16 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All goods and produce delivered into the actual or construction possession and all goods financed by the bank all bills receipts proceeds of sale all contracts letters of credit guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 16 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CONTINENTAL TRADE AND COMMODITY SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 août 2022Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Benjamin Stanyon
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    practitioner
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    Nedim Patrick Ailyan
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington
    practitioner
    Centre Block 4th Floor Central Court
    Knoll Rise
    BR6 0JA Orpington

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0