THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 01319261 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED ?
| Adresse du siège social | Five Canada Square Canary Wharf E14 5AQ London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 26 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2025 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2024 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023 | 7 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 7 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Claudia Bunney en tant que secrétaire le 03 janv. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 6 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 6 pages | AA | ||
Notification de Susan Louise Jenner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 mai 2020 | 2 pages | PSC01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 9th Floor the Thomson Reuters Building South Colonnade Canary Wharf London E14 5EP à Five Canada Square Canary Wharf London E14 5AQ le 24 févr. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de Stuart Nicholas Corbin en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 juin 2019 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de la nomination de Sarah Goudy en tant que directeur le 06 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Sarah Goudy en tant qu'administrateur le 02 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Stuart Nicholas Corbin en tant que directeur le 28 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Claudia Bunney le 31 oct. 2018 | 1 pages | CH03 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 5 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCKMANN, Nigel John William, Mr. | Administrateur | 21 Kingsbridge Road W10 6PU London | United Kingdom | British | 16049870002 | |||||
| HALL, Kim Elizabeth | Administrateur | Canary Wharf E14 5AQ London Five Canada Square United Kingdom | British | 124565570001 | ||||||
| HALL, Miranda Louise | Administrateur | South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 30 England England | England | British | 70528180001 | |||||
| JENNER, Susan Louise | Administrateur | Canary Wharf E14 5AQ London Five Canada Square United Kingdom | England | British | 45156020002 | |||||
| LARQUE, Neil Grant Stewart | Administrateur | South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 30 England England | British | 115959480001 | ||||||
| PATEL, Mayurkant | Administrateur | South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 30 England England | England | British | 159558310001 | |||||
| SHAWKAT, Haydar Suham | Administrateur | Avenue Road Swiss Cottage NW3 3PF London 100 United Kingdom | England | British | 89797290003 | |||||
| BUNNEY, Claudia | Secrétaire | 2 London Wall Place EC2Y 5AU London Barnett Waddingham United Kingdom | 146203800001 | |||||||
| BURGESS, Patricia Margaret | Secrétaire | 104 Selworthy Road Catford SE6 4DN London | British | 7575530001 | ||||||
| LUCK, Andrew Philip | Secrétaire | 8 Swansley Lane CB3 6BS Cambourne Cambridgeshire | British | 40653350002 | ||||||
| BARRETT, Elizabeth Anne, Dr | Administrateur | Brookside Cottage Upper Slaughter GL54 2JB Cheltenham Glos. | United Kingdom | British | 105138880002 | |||||
| BOSWELL, Ralph Henry | Administrateur | 95 Garner Road E17 4HG London | British | 2741160001 | ||||||
| BRADER, Susan Carol | Administrateur | 73 Greenwich South Street Greenwich SE10 8NT London | British | 67289920001 | ||||||
| BROCKMANN, Nigel John William, Mr. | Administrateur | 21 Kingsbridge Road W10 6PU London | United Kingdom | British | 16049870002 | |||||
| BURGESS, Patricia Margaret | Administrateur | 104 Selworthy Road Catford SE6 4DN London | British | 7575530001 | ||||||
| BUTLER, Adrian | Administrateur | 21 Jedburgh Street SW11 5QA London | British | 77442480001 | ||||||
| CASS, Amanda | Administrateur | Tudor Cottage 447 Woodham Lane KT15 3QG Woodham Surrey | British | 86198160001 | ||||||
| CLARKE, Angela | Administrateur | Floor Aldgate House 33 Aldgate High Street EC3N 1DL London 2nd United Kingdom | United Kingdom | British | 159545880001 | |||||
| COOK, John | Administrateur | 52 Regent Way GU16 5NT Frimley Surrey | British | 35553920002 | ||||||
| CORBIN, Stuart Nicholas | Administrateur | The Thomson Reuters Building South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 9th Floor | England | British | 86551230002 | |||||
| DANN, Clarissa Christine | Administrateur | 1b Claremont Road N6 5DA London | British | 62139350001 | ||||||
| DESBOROUGH, Linda Marian | Administrateur | 10 Birchen Close Woodcote RG8 0SW Reading Berkshire | British | 32108460001 | ||||||
| ENGLAND, Terence John | Administrateur | 5 Headley Chase CM14 5BN Brentwood Essex | British | 72215620001 | ||||||
| GILL, John Anthony Samuel | Administrateur | Brae Rise Berry Lane Worplesdon GU3 3QF Guildford Surrey | England | British | 13490001 | |||||
| GOUDY, Sarah | Administrateur | The Thomson Reuters Building South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 9th Floor | United Kingdom | British | 263379450001 | |||||
| GRANDAGE, Barbara Joan | Administrateur | 35 Meadway NW11 7AT London | British | 9109630001 | ||||||
| HALL, Kim Elizabeth | Administrateur | 25 Whitecroft BR8 7YH Swanley Kent | British | 72391730001 | ||||||
| HAMER, Timothy Frank | Administrateur | Byron Road AL5 4AB Harpenden 12 Hertfordshire | United Kingdom | British | 95617260001 | |||||
| HARDY, Thomas Richard Warwick | Administrateur | Bridge Cottage Cufaude Lane Bramley RG26 5DL Basingstoke Hampshire | British | 55112260001 | ||||||
| HICKS, David Marvin | Administrateur | 26 Riverdale Gardens TW1 2BZ Twickenham Middlesex | England | British | 107950240001 | |||||
| JENNER, Susan Louise | Administrateur | 79 Alder Lodge Stevenage Road, Fulham SW6 6NR London | England | British | 45156020002 | |||||
| JONES, Martin Bowen | Administrateur | 26 Longcroft Avenue AL5 2QZ Harpenden Hertfordshire | British | 55142340002 | ||||||
| KASSIMATIS, Aristides Emmanuel | Administrateur | 27 Courtenay Road SO23 7ER Winchester Hampshire | British | 49470910002 | ||||||
| LAKE, Peter William | Administrateur | 16 Elmfield Road Tooting SW17 8AL London | United Kingdom | British | 78374180001 | |||||
| LANCASTER, Maurice | Administrateur | 3 Larch Drive Gallagher's Copse SP10 3DE Andover Hampshire | British | 49701840001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE THOMSON CORPORATION PENSION TRUST LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Ms Susan Louise Jenner | 15 mai 2020 | Canary Wharf E14 5AQ London Five Canada Square United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr. Nigel John William Brockmann | 12 déc. 2016 | Kingsbridge Road W10 6PU London 21 United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Stuart Nicholas Corbin | 06 avr. 2016 | 30 South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 9th Floor, The Thomson Reuters Building United Kingdom | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr. Andrew Philip Luck | 06 avr. 2016 | 30 South Colonnade Canary Wharf E14 5EP London 9th Floor, The Thomson Reuters Building United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0