H P BULMER HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéH P BULMER HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01320906
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    H P BULMER HOLDINGS PLC27 juin 201327 juin 2013
    H P BULMER HOLDINGS P L C11 juil. 197711 juil. 1977

    Quels sont les derniers comptes de H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 08 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    4 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share prem reduced 24/11/2014
    RES13

    Cessation de la nomination de Sean Michael Paterson en tant que directeur le 08 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jospehus Petrus Adrianus Van Der Burg en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Malcolm Dunn en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Michael Forde en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anne Louise Oliver en tant que directeur le 06 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anne Louise Oliver en tant que secrétaire le 06 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Michael Paterson le 18 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Anne Louise Oliver le 18 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Kelly Taylor-Welsh le 18 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Anne Louise Oliver le 18 sept. 2013

    2 pagesCH03

    Subdivision des actions au 14 juin 2013

    5 pagesSH02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée

    2 pagesRR02

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    28 pagesMAR

    Qui sont les dirigeants de H P BULMER HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNN, Malcolm James Shiel
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish191401290001
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    TAYLOR-WELSH, Kelly
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish167915590003
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Secrétaire
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    British132259650001
    CLARKE, James
    21 Manor Close
    SG17 5EJ Clifton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    21 Manor Close
    SG17 5EJ Clifton
    Bedfordshire
    British33348740001
    DANIELS, Roger Michael
    Sunnybank Farm
    Venns Green
    HR1 3DD Sutton St Nicholas
    Herefordshire
    Secrétaire
    Sunnybank Farm
    Venns Green
    HR1 3DD Sutton St Nicholas
    Herefordshire
    British34854270002
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Secrétaire
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    British71528270003
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Secrétaire
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    RICHARDSON, Ian David Lea
    Gatehouse Farm
    Dinedor
    SE1 3RF Hereford
    Secrétaire
    Gatehouse Farm
    Dinedor
    SE1 3RF Hereford
    British73820300001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Secrétaire
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Administrateur
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritish132259650001
    BROWN, Colin Carlyle Campbell
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    British61755350001
    BULMER, David Edward
    Brilley Court
    Whitney On Wye
    HR3 6JF Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Brilley Court
    Whitney On Wye
    HR3 6JF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish17323090001
    BULMER, Giles Morwick
    The Old Rectory
    Credenhill
    HR4 7DJ Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Credenhill
    HR4 7DJ Hereford
    Herefordshire
    British15028850001
    BULMER, James Esmond
    Studley Royal House
    Studley Park
    HG4 3DY Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Studley Royal House
    Studley Park
    HG4 3DY Ripon
    North Yorkshire
    British17323080002
    BUTLER, Adam Courtauld, The Right Hon Sir
    The Old Rectory
    Lighthorne
    CV35 0AR Warwick
    Administrateur
    The Old Rectory
    Lighthorne
    CV35 0AR Warwick
    British3845890001
    COOKE, Roger Francis Adrian
    41 Thornhill Road
    Barnsbury
    N1 1JS London
    Administrateur
    41 Thornhill Road
    Barnsbury
    N1 1JS London
    British14493100001
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Administrateur
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritish79182280001
    EGGLETON, Jonathan Philip
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    Administrateur
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    British83396140001
    FLOCKHART, Alan Campbell
    55 Battenhall Road
    WR5 2BP Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    55 Battenhall Road
    WR5 2BP Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish110231660001
    FURSE, Timothy Machin
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    Administrateur
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    British32520640003
    HARVEY, John Michael
    Stamford House
    Locks Ride
    Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Stamford House
    Locks Ride
    Ascot
    Berkshire
    British54412030001
    HUGHES, Michael John
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish101949350001
    JAMET, Jean Francois
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    Administrateur
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    EnglandFrench83396080001
    KENNERLEY, Peter Dilworth
    13 Lennox Street
    EH4 1QB Edinburgh
    Administrateur
    13 Lennox Street
    EH4 1QB Edinburgh
    British69268560005
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Administrateur
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish162758370001
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    British1386650001
    NORTON, John Lindsey
    The Old Rectory Holwell
    DT9 5LB Sherborne
    Dorset
    Administrateur
    The Old Rectory Holwell
    DT9 5LB Sherborne
    Dorset
    British28999710002
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Administrateur
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish141021760002
    PAYNE, William John
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    Administrateur
    Scottsdale
    TD6 9QE Melrose
    5
    Roxburghshire
    ScotlandBritish136005370001
    PENNYCOOK, Richard John
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    British87825540001
    PRYCE, George Terry
    89 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QG Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    89 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QG Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish5773770001
    RUDGARD, John Kennish
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    British17349320001

    H P BULMER HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 15 janv. 2003
    Livré le 22 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Intercreditor Agent
    Transactions
    • 22 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0