VICTOR GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVICTOR GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01330212
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VICTOR GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe VICTOR GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cala House
    54 The Causeway
    TW18 3AX Staines
    Surrey
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VICTOR GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VICTOR HOMES LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    VICTOR SYSTEM HOMES LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    WULEIGH LIMITED15 sept. 197715 sept. 1977

    Quels sont les derniers comptes de VICTOR GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour VICTOR GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 juil. 2013

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 avr. 2013

    7 pages4.68

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    5 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 avr. 2012

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 avr. 2012

    État du capital au 24 avr. 2012

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Block B Burgan House the Causeway Staines Middlesex TW18 3PR le 02 mars 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    5 pagesAA

    legacy

    15 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    5 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Alan Downie en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Ball en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan Duke Brown en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    7 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de VICTOR GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004
    BROWN, Alan Duke
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    Administrateur
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    EnglandBritish32640750005
    REID, John Graham Gunn
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish54537790003
    WARD, Arnold Geoffrey
    7 Holmsley Garth
    Woodlesford
    LS26 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    7 Holmsley Garth
    Woodlesford
    LS26 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    British7510670001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BALL, Geoffrey Arthur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish246030002
    DICK, Robert John Westwater
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    Administrateur
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    British246770002
    DOWNIE, Alan Wood
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish248110001
    EAMES, Malcolm Russell
    19 Grove Crescent South
    Boston Spa
    LS23 6AY Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    19 Grove Crescent South
    Boston Spa
    LS23 6AY Wetherby
    West Yorkshire
    British26059770001
    FLEMING, Peter Maclean
    52 Falcon Road
    BD16 4DW Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    52 Falcon Road
    BD16 4DW Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish43012300001
    KENT, Kathleen
    15 Mayfield Grove
    Wilsden
    BD15 0EY Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    15 Mayfield Grove
    Wilsden
    BD15 0EY Bradford
    West Yorkshire
    British7510700001
    MORE, Gerald Campbell
    37 Morningside Drive
    EH10 5LZ Edinburgh
    Administrateur
    37 Morningside Drive
    EH10 5LZ Edinburgh
    British66976580001
    PRESTON, James Jackson Wilson
    West Ghyll
    21 Victoria Avenue
    LS29 9BW Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    West Ghyll
    21 Victoria Avenue
    LS29 9BW Ilkley
    West Yorkshire
    British57938300004
    WILLETTS, Franklyn Nigel
    46 Lane End
    LS28 9AD Pudsey
    West Yorkshire
    Administrateur
    46 Lane End
    LS28 9AD Pudsey
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26059780002

    VICTOR GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 07 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC ( the “Security Trustee”)
    Transactions
    • 07 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 21 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2009
    Livré le 23 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of charge
    Créé le 08 juil. 1994
    Livré le 20 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from victor group limited to the governor and company of the bank of scotland under or pursuant to the terms of the charge.
    Brèves mentions
    All monies now or at any time herafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books,.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 20 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1991
    Livré le 26 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 woodside road boston spa wetherby west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Building Society
    Transactions
    • 26 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1991
    Livré le 26 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 applerley lane yeadon wst yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Building Society
    Transactions
    • 26 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1991
    Livré le 26 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    5 bolehill park brighouse west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Building Society
    Transactions
    • 26 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1991
    Livré le 26 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    22 george lane calverton nottingham.
    Personnes ayant droit
    • National & Provincial Building Society
    Transactions
    • 26 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1991
    Livré le 26 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    23 oakwell avenue batley west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • National & Provincial Building Society
    Transactions
    • 26 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 1991
    Livré le 23 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge not exceeding £1,000,000.
    Brèves mentions
    Any properties purchased by the company in part exchange for new properties sold out.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Building Society
    Transactions
    • 23 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 1990
    Livré le 17 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land fronting hall lane northawram hall halifax west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land on the north side of abbotsford road york north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land on north side of intake place bromley west yorkshire title no wyk 422779.
    Personnes ayant droit
    • The Governor Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land in the north east side of fieldhead lane and birstall lane droghlington leeds w yorkshire title no wyk 354895.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    9, 11 and 13 hyde terrace leeds together with lind & buildings lying to the west side of hyde place leeds w yorkshire title no:- wyk 418184 wyk 4181848 wyk 418185, wyk 4300778.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Providence works marsh pudsey w yorkshire title no 408594.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land lying to the smith of brownhill rd and on the east side of quarry lane and on the north of norwood drive birstall w yorkshire title no wyk 334272.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 juil. 1989
    Livré le 25 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at rear of oaks cottage boston spa west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge registered pursuant to an order of court 17/8/89
    Créé le 26 janv. 1989
    Livré le 30 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that f/h plot of land situate to the rear of oaks cottage oaks lane boston spa west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1988
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All those two, plots of land at laven thorpe lane thornton bradford w yorkshire title no:- wyk 420635.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1988
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Firstly willow cottage willow lane clifford west yorkshire secondly land comprising part of the croft albion street clifford west yorkshire title no wyk 335345.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1988
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    East cottingworth arms (formerly k/a the bluebell inn) east cottingwith humberside title no hs 29802.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 déc. 1988
    Livré le 04 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and or all of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Berkeley house, clarendon rd, leeds, west yorkshire title no ywe 54478 wnd WK419864.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 nov. 1988
    Livré le 02 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at fieldhead lane, drighlington, leeds. The borrower as beneficial owner hereby charges by way of legal mortgage all and singular the above property together with all fixtures other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1988
    Livré le 24 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings a north side of abbotsford road york north yorkshire together with all fixtures whatseover now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Personnes ayant droit
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transactions
    • 24 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    VICTOR GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 oct. 2013Dissolved on
    19 avr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Donald Mckinnon
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    practitioner
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0