TQ TRAINING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTQ TRAINING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01331467
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TQ TRAINING LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TQ TRAINING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TQ TRAINING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TECQUIPMENT LIMITED31 juil. 200031 juil. 2000
    TQ EDUCATION AND TRAINING LIMITED03 févr. 200003 févr. 2000
    TECQUIPMENT INTERNATIONAL LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    TECQUIPMENT INTERNATIONAL CONTRACTS LIMITED26 sept. 197726 sept. 1977

    Quels sont les derniers comptes de TQ TRAINING LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2015
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2016
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour TQ TRAINING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 80 Strand London WC2R 0RL England à Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER le 03 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 nov. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Joseph Anthony Carroll en tant que directeur le 10 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de The Pearson Academy of Vocational Training Bangrave Road Corby Northamptonshire NN17 1NN à 80 Strand London WC2R 0RL le 12 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2015

    État du capital au 07 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Charles Keith Scobie le 01 déc. 2014

    3 pagesCH01

    Nomination de Joseph Anthony Carroll en tant qu'administrateur le 01 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sean Nicholas Price en tant que directeur le 30 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2014

    État du capital au 14 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Charles Keith Scobie en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Parr en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 08 juil. 2013

    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Mr. Martyn James Allen Leader en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Sean Nicholas Price en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Victor Keyworth en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew William Parr en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Butler en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TQ TRAINING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DALE, Natalie Jane
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    Secrétaire
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    British173139770001
    JONES, Stephen Andrew
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    Secrétaire
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    British170332830001
    LEADER, Martyn James Allen, Mr.
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    Administrateur
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    EnglandBritishTq Director Of Outsourced Learning171894810001
    SCOBIE, Charles Keith, Mr.
    High Holborn
    WC1V 7BH London
    190
    England
    Administrateur
    High Holborn
    WC1V 7BH London
    190
    England
    EnglandBritishAccountant185944630001
    HIRANI, Daksha
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    United Kingdom
    Secrétaire
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    United Kingdom
    166373570001
    MILSOM, Helen Ruth
    9 Yew Tree Gardens
    Rosliston
    DE12 8JG Swadlincote
    Derbyshire
    Secrétaire
    9 Yew Tree Gardens
    Rosliston
    DE12 8JG Swadlincote
    Derbyshire
    British27406000002
    MURRAY, John Christopher
    16 Ashworth Crescent
    Mapperley
    NG3 6BX Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    16 Ashworth Crescent
    Mapperley
    NG3 6BX Nottingham
    Nottinghamshire
    British13003940001
    BUTLER, Christopher
    Bangrave Road
    NN17 1NN Corby
    The Pearson Academy Of Vocational Training
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bangrave Road
    NN17 1NN Corby
    The Pearson Academy Of Vocational Training
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritishDirector112702140001
    CARROLL, Joseph Anthony
    WC2R 0RL London
    80 Strand
    England
    Administrateur
    WC2R 0RL London
    80 Strand
    England
    EnglandIrishDirector, Uk Financial Control187819340001
    COPE, John Richard
    74 Northwold Avenue
    West Bridgford
    NG2 7LQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    74 Northwold Avenue
    West Bridgford
    NG2 7LQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector5571710001
    DAVIES, Richard Arthur
    Lammas Close
    NN14 1JJ Orlingbury
    4
    Northamptonshire
    Administrateur
    Lammas Close
    NN14 1JJ Orlingbury
    4
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector132066370001
    KEYWORTH, Victor Edward
    Bangrave Road
    NN17 1NN Corby
    The Pearson Academy Of Vocational Training
    Northamptonshire
    Administrateur
    Bangrave Road
    NN17 1NN Corby
    The Pearson Academy Of Vocational Training
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector105111630001
    MURRAY, John Christopher
    16 Ashworth Crescent
    Mapperley
    NG3 6BX Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    16 Ashworth Crescent
    Mapperley
    NG3 6BX Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector13003940001
    PARR, Andrew William
    Bangrave Road
    NN17 1NN Corby
    Northamptonshire
    Administrateur
    Bangrave Road
    NN17 1NN Corby
    Northamptonshire
    EnglandBritishAccountant173753440001
    POPE, Evelyn Alice, Lady
    3 Mapperley Hall Drive
    Mapperley
    NG3 5EP Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    3 Mapperley Hall Drive
    Mapperley
    NG3 5EP Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector13003950001
    PRICE, Sean Nicholas
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    Administrateur
    Strand
    WC2R 0RL London
    80
    England
    United Arab EmiratesBritishRegional General Manager Mena176920730001

    TQ TRAINING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 déc. 1991
    Livré le 24 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank
    Transactions
    • 24 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 nov. 1991
    Livré le 13 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee and debenture
    Créé le 27 janv. 1981
    Livré le 16 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All that property, undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    • 02 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 20 oct. 1977
    Livré le 28 oct. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings. Fixtures fixed plant and machinery (please see doc M6).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1977Enregistrement d'une charge
    • 02 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TQ TRAINING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 nov. 2015Commencement of winding up
    07 avr. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0