JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED

JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJEEVES INTERNATI0NAL LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01339567
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    • Lavage et nettoyage (à sec) de produits textiles et de fourrure (96010) / Autres activités de services

    Où se situe JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Timpson House Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JEEVES OF BELGRAVIA INTERNATIONAL LIMITED18 nov. 197718 nov. 1977

    Quels sont les derniers comptes de JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de James Timpson en tant que directeur le 05 juil. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2023

    10 pagesAA

    legacy

    52 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 01 oct. 2022

    10 pagesAA

    legacy

    48 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 25 sept. 2021

    10 pagesAA

    legacy

    49 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    47 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 26 sept. 2020

    11 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-documents/co business 03/07/2020
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Statuts

    8 pagesMA

    Inscription de la charge 013395670006, créée le 03 juil. 2020

    13 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale établis au 28 sept. 2019

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAJITHIA, Paresh
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Administrateur
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    EnglandBritishFinance Director95207500003
    TIMPSON, William John Anthony, Sir
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Administrateur
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    EnglandBritishDirector7391320001
    BRICE, Stephen John
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Secrétaire
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    199880870001
    CLUTSON, Simon Scott
    26 Kenilworth Road
    SE20 7QG London
    Secrétaire
    26 Kenilworth Road
    SE20 7QG London
    BritishFinancial Manager104189320001
    HUMPAGE, Benjamin Mark
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    Secrétaire
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    154902410001
    JACOBS, Ronald Martin
    Flat 16 Salisbury House
    Gordon Avenue
    HA7 3QR Stanmore
    Middlesex
    Secrétaire
    Flat 16 Salisbury House
    Gordon Avenue
    HA7 3QR Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor21688220005
    JOHNSTONE, John Barrie
    2l Long Close
    Botley
    OX2 9SG Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    2l Long Close
    Botley
    OX2 9SG Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector99467460001
    WARD, James Robert
    Frieston
    Foxley Road
    SN16 0JF Malmesbury
    Wilts
    Secrétaire
    Frieston
    Foxley Road
    SN16 0JF Malmesbury
    Wilts
    British,Finnish78453150002
    WOOD, Ruth Christine
    Puma Court Kings Business Park
    Kings Drive
    L34 1PJ Liverpool
    Lydia House
    Merseyside
    Secrétaire
    Puma Court Kings Business Park
    Kings Drive
    L34 1PJ Liverpool
    Lydia House
    Merseyside
    BritishDirector/Co.Sec34803080002
    WOOD, Ruth Christine
    54 Dunbar Crescent
    Hillside
    PR8 3AB Southport
    Merseyside
    Secrétaire
    54 Dunbar Crescent
    Hillside
    PR8 3AB Southport
    Merseyside
    British34803080002
    BECKERMAN, Norman
    18 Walker Close
    N11 1AQ London
    Administrateur
    18 Walker Close
    N11 1AQ London
    BritishRetail Jeweller45089570001
    BRICE, Stephen John
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Administrateur
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    United KingdomBritishFinance Director199879120001
    DAINES, Robert William John
    6 First Avenue Breach Barn Place
    Galley Hill
    EN9 2AL Waltham Cross
    Administrateur
    6 First Avenue Breach Barn Place
    Galley Hill
    EN9 2AL Waltham Cross
    BritishCompany Director26546660002
    ELLIOTT, Thomas Andrew
    Edgehill
    Pastens Road
    RH8 0RE Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Edgehill
    Pastens Road
    RH8 0RE Oxted
    Surrey
    BritishDirector17958160003
    HUMPAGE, Benjamin Mark
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    Administrateur
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    EnglandBritishFinance Director154902330001
    JACOB, Sydney Dennis
    Cooks Lodge
    College Road
    BA1 5RU Lansdowne
    Bath
    Administrateur
    Cooks Lodge
    College Road
    BA1 5RU Lansdowne
    Bath
    EnglandBritishDirector3229460011
    JACOBS, Ronald Martin
    Flat 16 Salisbury House
    Gordon Avenue
    HA7 3QR Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Flat 16 Salisbury House
    Gordon Avenue
    HA7 3QR Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor21688220005
    JOHN, Stephen Laurel
    26 Oaklands Avenue
    RM1 4DB Romford
    Essex
    Administrateur
    26 Oaklands Avenue
    RM1 4DB Romford
    Essex
    United KingdomBritishLegal Executive67563970002
    JOHNSTONE, John Barrie
    2l Long Close
    Botley
    OX2 9SG Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    2l Long Close
    Botley
    OX2 9SG Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector99467460001
    MASON, Shaun
    97 Harwoods Lane
    Rossett
    LL12 0EU Wrexham
    Clwyd
    Administrateur
    97 Harwoods Lane
    Rossett
    LL12 0EU Wrexham
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector102520780001
    MCMICHAEL, Anthony Terence
    24 Cavendish Road East
    NG7 1BB Nottingham
    Administrateur
    24 Cavendish Road East
    NG7 1BB Nottingham
    EnglandBritishCompany Director48787310001
    MOATE, Simon Richard
    Carlton No 50
    Burford Road
    OX28 6DR Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Carlton No 50
    Burford Road
    OX28 6DR Witney
    Oxfordshire
    BritishDirector126182400001
    MONAGHAN, Yvonne May
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    Administrateur
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    EnglandBritishDirector7934540003
    OGLE, Paul Derek, Mr.
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    Administrateur
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    EnglandBritishDirector73043500004
    SANDER, Christopher
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    Administrateur
    Pittman Way
    Fulwood
    PR2 9ZD Preston
    Jeeves International Limited
    England
    EnglandBritishDirector27648050003
    SCOOTS, Martin Alexander
    2 Lady Place Cottages
    SL6 6RF Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    2 Lady Place Cottages
    SL6 6RF Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector93530650001
    TIMPSON, James
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Administrateur
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    EnglandBritishDirector163192300001
    WOOD, Ruth Christine
    Puma Court Kings Business Park
    Kings Drive
    L34 1PJ Liverpool
    Lydia House
    Merseyside
    Administrateur
    Puma Court Kings Business Park
    Kings Drive
    L34 1PJ Liverpool
    Lydia House
    Merseyside
    EnglandBritishDirector34803080002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    06 avr. 2016
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Oui
    Forme juridiqueUk Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02339274
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Jeeves Of Belgravia Limited
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    06 avr. 2016
    Claverton Road
    Roundthorn Industrial Estate
    M23 9TT Manchester
    Timpson House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    JEEVES INTERNATI0NAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 juil. 2020
    Livré le 08 juil. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 janv. 2017
    Livré le 10 janv. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 21 févr. 2014
    Livré le 25 févr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 08 janv. 2010
    Livré le 15 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged please see MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 18 avr. 2008
    Livré le 06 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transactions
    • 06 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2008
    • 15 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 21 janv. 2008
    Livré le 31 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent for National Westminster Bank PLC)
    Transactions
    • 31 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0