PROUDALE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROUDALE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01349564
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROUDALE LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe PROUDALE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PROUDALE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PROUDALE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PROUDALE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Juliet Mary Susan Bellis en tant que secrétaire le 01 sept. 2015

    1 pagesTM02

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 20 juil. 2015

    18 pages2.35B

    Cessation de la nomination de Lucy Clare Cummings en tant que directeur le 01 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Graham Bellis en tant que directeur le 01 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 avr. 2015

    24 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 oct. 2014

    23 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 avr. 2014

    23 pages2.24B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    13 pages2.39B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 oct. 2013

    22 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 mai 2013

    21 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    21 pages2.31B

    legacy

    3 pagesMG02

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 déc. 2012

    8 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 23 juil. 2012

    22 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    23 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    23 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * Hangar 4 Shoreham Airport Shoreham-by-Sea West Sussex BN43 5FF* le 05 mars 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 janv. 2012

    État du capital au 04 janv. 2012

    • Capital: GBP 73
    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable précédente raccourcie du 31 oct. 2010 au 30 sept. 2010

    1 pagesAA01

    legacy

    10 pagesMG01
    Annotations
    DateAnnotation
    11 juil. 2011This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2010 au 31 oct. 2010

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de PROUDALE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Secrétaire
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    BritishSolicitor69991160002
    MOSS, Beverly Ruth
    Fairways Golf Club Drive
    Coombe Hill
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Fairways Golf Club Drive
    Coombe Hill
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British41078900001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Administrateur
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    BritishSolicitor69991160002
    BELLIS, Neil Graham
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Administrateur
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritishBarrister61569970003
    CUMMINGS, Lucy Clare
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Administrateur
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritishConsultant80559730002
    MOSS, Beverly Ruth
    Fairways Golf Club Drive
    Coombe Hill
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Fairways Golf Club Drive
    Coombe Hill
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishSecretary41078900001
    MOSS, Claire Lisa
    Flat 1
    39 Belsize Square
    NW3 4HL London
    Administrateur
    Flat 1
    39 Belsize Square
    NW3 4HL London
    BritishDentist66520110001
    MOSS, Jerry
    Flat 26 South Lodge
    45 Leigham Court Road
    SW16 2NF Streatham
    London
    Administrateur
    Flat 26 South Lodge
    45 Leigham Court Road
    SW16 2NF Streatham
    London
    BritishQuality Control Executive (Ret21157420002
    MOSS, Michael Anthony
    Fairways Golf Club Drive
    Coombe Hill
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    Fairways Golf Club Drive
    Coombe Hill
    KT2 7DF Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishSolicitor21157430001

    PROUDALE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 28 juin 2011
    Livré le 11 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 70 to 92 (even numbers) colemans moor road, woodley, BK232851. F/h flats 1 to 8 inclusive chase gardens and garages, 1 to 8 inclusive and 13 to 22 inclusive chase gardens, chingford, t/no: EX68515 and f/h flats 13 to 22 inclusive, chase gardens, chingford, london, t/no: EX74111. (For details of all other property charged, please refer to the MG01 document).
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 11 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 25 avr. 2008
    Livré le 14 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 août 2006
    Livré le 24 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 24 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 22 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 mai 2000
    Livré le 18 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/hold property known as 1-7 (all) & garages 1-10 (all) eaton close bourne street london borough of the city of westminster t/no:LN179693. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property known as 4,5 and 6 cliveden place and 1,2 and 3 bourne st,london borough of city of westminster; t/no NGL232512. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mars 1995
    Livré le 13 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The six various f/h properties as listed in the form 395 including (1) chimneys court, 40 arterberry road, wimbledon, london t/no. SY4803 (2) 1/23 lantern court, 97/99 warpole road, wimbledon, london t/no. SY488160 and (3) flats 1/16 park view, 201 ewell road, surbiton, surrey t/no. TGL49715 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 juin 1994
    Livré le 04 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H properties k/a:- 1) 98/98A/100/100A/102/102A/104/104A watling street bexley; 2) 1A to 1F crayford road crayford and garages 1/6; 3) 120/158 (even numbers) larch crescent 49-63 (odd numbers) mimosa road 87/101 (odd numbers) larch crescent 18/40 (even numbers) yeading fork hayes middlesex; 4) 1/4 welldon house high street nutfield; 5) 70/92 (even numbers) colemans moor road woodley t/n's K164814, K136002, MX451966, SY507809 and BK232851 respectively and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 mai 1994
    Livré le 31 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a salter court 25 montague road, l/b of merton t/no: SY281484 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 mars 1994
    Livré le 29 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a neald court 25 stanley road london SW19, t/n SGL39821, bramlands court 24 stanley road london SW19 t/n SY79391,selbridge court 35/41 princes road london SW19, t/NSGL102179 and kingsley court 22 the avenue worcester park t/n SY377048 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 août 1993
    Livré le 06 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H sunnyhill court sunnyhill road parkstone poole dorset t/n DT143705 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 août 1989
    Livré le 21 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 6 alden court and garage c 29 stanley road, london borough of merton title no sy 310084 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 mars 1989
    Livré le 04 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 5 and garage 9 neald court, stanley road, wimbledon SW19 title no sgl 54564 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 nov. 1986
    Livré le 14 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £33,600
    Brèves mentions
    24 ashley way, brighstone, nr. Freshwater, isle of wight.
    Personnes ayant droit
    • Alfred George Rex
    • Elsie Rex
    Transactions
    • 14 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 avr. 1986
    Livré le 06 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    23, commonside west, mitcham in the london borough of melton and/or the proceeds of sale thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 juil. 1984
    Livré le 19 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H of garages at rear of lesley ct. Southcote rd reading berks. 1-12 & 14-29 tn bk 160607 &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 sept. 1983
    Livré le 01 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 seperate blocks of flats and car spares as an attached schedule see doc M28 for details and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 juil. 1983
    Livré le 22 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and lock up garages at rear of cromberdale court lansdown rd tottenham london.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juil. 1983
    Livré le 15 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H dallas court dallas rd cheam london title no. Sy 130807.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 mars 1983
    Livré le 26 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H blocks of flats, garages and parking spares as in schedule (see doc 24) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1983Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 nov. 1982
    Livré le 13 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & buildings lying to the east of western road known as garage 14 (formerly 11) and car parking spaces 45/47 cypress court, cheam road, sutton and/or the proceeds of sale thereof title no. Sgl 336877. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 mars 1982
    Livré le 08 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hadrian court stanley road sutton title no. Sy 280058 fairford court stanley road sutton title no. Sy 141745 dorland court 106 west hill putney SW15 title no. 216601 416 wimbledon park road wimbledon SW19 title no. 449265. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 nov. 1981
    Livré le 24 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Properties named on doc M20.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 oct. 1981
    Livré le 06 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Properties named on doc- M19.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1981Enregistrement d'une charge
    • 21 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PROUDALE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 janv. 2012Administration started
    20 juil. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Edward Reed
    Pricewaterhousecoopers Llp Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0