BMI (NO.6) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBMI (NO.6) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01353901
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BMI (NO.6) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BMI (NO.6) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BMI (NO.6) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BMI (NO.6) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BMI (NO.6) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:statement of accounts approval
    1 pagesLIQ MISC RES

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 Churchill Place London E14 5HP à Barclays Group Archives Dallimore Road Wythenshore Manchester M23 9VA

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Churchill Plaza Churchill Way Basingstok Hampshire RG21 7GP à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 01 juin 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 mai 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mai 2015

    État du capital au 13 mai 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Mohammed Akram en tant que directeur le 13 mars 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2014

    État du capital au 16 mai 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Gavin John Simpson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Duncan Rowberry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Mohammed Akram en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Geoffrey Ridout en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Jeremy Marchant en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jeremy Marchant en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    24 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BMI (NO.6) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secrétaire
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HASSELL, Brian Charles
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Blenheim Close
    CM21 0BE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Great BritainBritish45384250002
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MARCHANT, Jeremy
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish154144600001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Administrateur
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    BMI (NO.6) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Secondary lease security assignment
    Créé le 30 déc. 1992
    Livré le 13 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30TH december 1992
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the assigned payments and all sums assigned pursuant to the security assignment (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublessee security agreement
    Créé le 30 déc. 1992
    Livré le 14 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Performance of certain covenants due or to become due from the company to triborough bridge and tunnel authority under the terms of the sublease d/d 24/11/92 and from the company under the terms of the head lease d/d 24/11/92
    Brèves mentions
    All of the company's right title and interest in the head lease and in the head security agreement (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transactions
    • 14 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BMI (NO.6) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 mai 2015Commencement of winding up
    16 janv. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0