REDHEAD FREIGHT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREDHEAD FREIGHT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01355753
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REDHEAD FREIGHT LIMITED ?

    • Transport routier de marchandises (49410) / Transports et stockage
    • Exploitation d'entrepôts et de terminaux de stockage pour le transport terrestre (52103) / Transports et stockage

    Où se situe REDHEAD FREIGHT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REDHEAD FREIGHT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour REDHEAD FREIGHT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Nomination de Mr John Mark Gillam en tant qu'administrateur le 03 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Aaron Scott en tant que directeur le 03 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 mars 2023

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement d'adresse du siège social de Schenker House Scylla Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 3FE England à Units 1-3 Hilltop Business Park Devizes Road Salisbury Wiltshire SP3 4UF le 08 avr. 2023

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Declan Joseph Byrne en tant que directeur le 20 mars 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    That the memorandum of association of the company be and is hereby removed with immediate effect 21/10/2022
    RES13

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2021

    37 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Ms Nichola Claire Watts en tant que secrétaire le 31 mai 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Keith Michael Shackleton en tant que secrétaire le 31 mai 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 17 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    35 pagesAA

    Nomination de Mr Declan Joseph Byrne en tant qu'administrateur le 01 juin 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Aaron Scott en tant qu'administrateur le 01 juin 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Spencer Cosgrove en tant que directeur le 01 juin 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Anthony Suggitt en tant que directeur le 01 juin 2021

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Freightspeed House Woodroyd Industrial Estate Dealburn Road, Low Moor Bradford BD12 0RG à Schenker House Scylla Road London Heathrow Airport Hounslow TW6 3FE le 28 mai 2021

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Philip Andrew Baxter en tant que directeur le 26 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de REDHEAD FREIGHT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATTS, Nichola Claire
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    Secrétaire
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    297395770001
    GILLAM, John Mark
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    Administrateur
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    EnglandBritish117224540004
    DERRY, Michael John
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Secrétaire
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    British21636860002
    SHACKLETON, Keith Michael
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Secrétaire
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    159083830001
    ADAMSON, Gerard Nicholas Paul
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Administrateur
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandEnglish74467030001
    ADAMSON, Gerard Nicholas Paul
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Administrateur
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandEnglish74467030001
    BAXTER, Philip Andrew
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Administrateur
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    United KingdomEnglish89307610002
    BYRNE, Declan Joseph
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Administrateur
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    IrelandIrish283914830001
    COCKROFT, Robert Michael
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Administrateur
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    United KingdomBritish168058660002
    COSGROVE, Mark Spencer
    Mallusk Drive
    BT36 4GX Newtownabbey
    5
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    Mallusk Drive
    BT36 4GX Newtownabbey
    5
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish140466750004
    DERRY, Michael John
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Administrateur
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandBritish21636860002
    HEIKEN, Reiner
    Edmund-Rumpler-Str. 3
    60549 Frankfurt
    Schenker Europe Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Edmund-Rumpler-Str. 3
    60549 Frankfurt
    Schenker Europe Gmbh
    Germany
    GermanyGerman244535340001
    JOHNSTON, David
    2 Cooper Close
    Lady Lane
    BD16 4SD Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Cooper Close
    Lady Lane
    BD16 4SD Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish58080390001
    KAISER, Ewald
    Colmore Row
    B3 2AB Birmingham
    Mills & Reeve Llp, 78-84
    United Kingdom
    Administrateur
    Colmore Row
    B3 2AB Birmingham
    Mills & Reeve Llp, 78-84
    United Kingdom
    GermanyGerman205093650001
    LUXTON, Richard Herbert
    33 Bromley Road
    Nab Wood
    BD18 4DT Shipley
    West Yorkshire
    Administrateur
    33 Bromley Road
    Nab Wood
    BD18 4DT Shipley
    West Yorkshire
    British57400420001
    REDHEAD, Jack
    Manor Barn Horners Fold
    Greeen End Road East Morton
    BD20 5TU Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Manor Barn Horners Fold
    Greeen End Road East Morton
    BD20 5TU Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish80279510001
    RUSSAM, Reginald Charles Lancaster
    The Bungalow
    Leeds Old Road
    BD3 7EW Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Bungalow
    Leeds Old Road
    BD3 7EW Bradford
    West Yorkshire
    British21636910001
    SCOTT, Aaron
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    Administrateur
    Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Units 1-3
    Wiltshire
    EnglandEnglish321518690001
    SUGGITT, Paul Anthony
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Administrateur
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    EnglandBritish21636880004
    THACKER, Robert Ian
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    Administrateur
    Freightspeed House
    Woodroyd Industrial Estate
    BD12 0RG Dealburn Road, Low Moor
    Bradford
    EnglandBritish21636900002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDHEAD FREIGHT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    30 oct. 2020
    Scylla Road
    London Heathrow Airport
    TW6 3FE Hounslow
    Schenker House
    England
    Non
    Forme juridiqueLtd
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00383914
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Schenker Aktiengesellschaft
    Kruppstrasse
    Essen
    4
    45128
    Germany
    06 avr. 2016
    Kruppstrasse
    Essen
    4
    45128
    Germany
    Oui
    Forme juridiqueJoint Stock Corporation
    Pays d'enregistrementGermany
    Autorité légaleGerman
    Lieu d'enregistrementEssen Commercial Register
    Numéro d'enregistrementHrb 17474
    Rechercher dans le registre du commerce allemandSchenker Aktiengesellschaft
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    REDHEAD FREIGHT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 15 oct. 2005
    Livré le 03 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Unit 13 northwest business park ballycoolin dublin 15.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transactions
    • 03 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Solicitors undertaking executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Créé le 27 juin 2005
    Livré le 14 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Unit 13, northwest business park, ballycoolin, dublin 15.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transactions
    • 14 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 01 nov. 2002
    Livré le 07 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the east side of spartan road low moor bradford west yorkshire t/n WYK193547. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 févr. 2001
    Livré le 09 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land and buildings on the south side of dealburn road low moor bradford t/n WYK570920. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2001
    Livré le 09 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2020L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 28 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 05 sept. 1997
    Livré le 18 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 1995
    Livré le 22 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H land containing approx. 4.75 acres at dealburn road low moor bradford west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • City of Bradford Metropolitan Council
    Transactions
    • 22 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 1995
    Livré le 21 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at dealburn road low moor bradford comprising approximately 4.75 acres, west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 07 avr. 1993
    Livré le 15 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,177.81 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M191C for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 15 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Prompt credit application
    Créé le 11 mai 1992
    Livré le 27 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15,940.30
    Brèves mentions
    All right title & interest in & to all sums payable....under the insurance (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers LTD
    Transactions
    • 27 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1987
    Livré le 13 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the south west side of dealburn road, law moor, bradford, west yorkshire title no - wyk 288973.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 1986
    Livré le 19 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 mars 1982
    Livré le 07 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1982Enregistrement d'une charge

    REDHEAD FREIGHT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 mars 2023Commencement of winding up
    27 juin 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Powell
    Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    practitioner
    Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    Julie Anne Palmer
    Begbies Traynor (Central) Llp Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp Units 1-3 Hilltop Business Park
    Devizes Road
    SP3 4UF Salisbury
    Wiltshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0