SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

SG LEASING (UTILITIES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSG LEASING (UTILITIES) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01364426
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BMI (NO.3) LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    DANNYWELANT LIMITED21 avr. 197821 avr. 1978

    Quels sont les derniers comptes de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 juin 2022

    7 pagesLIQ03

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    104 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement d'adresse du siège social de 10 Fleet Place London EC4M 7QS à C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB le 04 juil. 2022

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 15 Canada Square London E14 5GL à 10 Fleet Place London EC4M 7QS le 14 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England à 15 Canada Square London E14 5GL le 14 juil. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 juin 2021

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Cessation de la nomination de Lindsay Ginnette Sides en tant que directeur le 04 juin 2021

    1 pagesTM01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom à C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG à One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG le 18 nov. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Shields en tant que directeur le 20 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stuart Donald Cook en tant que directeur le 05 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Lethbridge Fowler le 20 sept. 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr. Paul Shields en tant qu'administrateur le 19 mars 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BALINSKA-JUNDZILL, Catherine
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Secrétaire
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    191477830001
    DENT, Nicholas Michael
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Administrateur
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish43922780002
    FOWLER, Stephen Lethbridge
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Administrateur
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    EnglandBritish135237620002
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secrétaire
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secrétaire
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Administrateur
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Administrateur
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    COOK, Stuart Donald
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    United KingdomBritish191477240004
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Administrateur
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    EVANS, Christopher Hewitt
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British121774150001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish127470250001
    HUCKLE, Jonathan Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish163223760001
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILES, Martin Graham
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish108439150001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Administrateur
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    NIMMO, Mark Alexander
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    United Kingdom
    EnglandBritish33420600001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROSE, Stephen George
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British143870380001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SHIELDS, Paul
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    Administrateur
    c/o C/O Group Legal
    House
    41 Tower Hill
    EC3N 4SG London
    Sg
    EnglandBritish244361960001
    SIDES, Lindsay Ginnette
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    Administrateur
    Canary Wharf
    E14 4SG London
    One Bank Street
    England
    EnglandBritish212141970001
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandIrish122291210001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SG LEASING (UTILITIES) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Société Générale
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    06 avr. 2016
    Boulevard Haussmann
    75009 Paris
    29
    France
    Non
    Forme juridiqueSociété Anonyme (French Public Limited Company)
    Pays d'enregistrementFrance
    Autorité légaleFrench Monetary And Financial Code And French Commercial Code
    Lieu d'enregistrementRegistre Du Commerce Et Des Sociétés - Greffe Du Tribunal De Commerce De Paris (Infogreffe - Les Greffes Des Tribunaux De Commerce)
    Numéro d'enregistrement552 120 222 00013 (Trade Register: 552 120 222 R.C.S. Paris)
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    SG LEASING (UTILITIES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Secondary lease security assignment
    Créé le 30 déc. 1992
    Livré le 14 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-lessee security agreement
    Créé le 30 déc. 1992
    Livré le 14 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92
    Brèves mentions
    All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transactions
    • 14 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority statutory mortgage
    Créé le 18 déc. 1986
    Livré le 07 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86
    Brèves mentions
    64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 18 déc. 1986
    Livré le 07 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed
    Brèves mentions
    The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Financial agreement
    Créé le 11 oct. 1985
    Livré le 14 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985
    Brèves mentions
    All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Shipowners agreement
    Créé le 01 oct. 1985
    Livré le 14 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement
    Brèves mentions
    Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36).
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 14 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 18 mars 1985
    Livré le 03 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85
    Brèves mentions
    All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transactions
    • 03 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority statutory mortgage
    Créé le 18 mars 1985
    Livré le 03 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85
    Brèves mentions
    64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transactions
    • 03 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 28 févr. 1985
    Livré le 12 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985
    Brèves mentions
    All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank.
    Transactions
    • 12 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    SG LEASING (UTILITIES) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 juin 2021Commencement of winding up
    21 oct. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0