ANKER SYSTEMS

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéANKER SYSTEMS
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 01365105
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ANKER SYSTEMS ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ANKER SYSTEMS ?

    Adresse du siège social
    Oracle Parkway
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ANKER SYSTEMS ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ANKER SYSTEMS LIMITED31 mars 200031 mars 2000
    RIVA SYSTEMS LIMITED26 sept. 198826 sept. 1988
    RIVA TURNKEY COMPUTER SYSTEMS LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    BENCHWORLD LIMITED25 avr. 197825 avr. 1978

    Quels sont les derniers comptes de ANKER SYSTEMS ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour ANKER SYSTEMS ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016

    11 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-registration 22/12/2016
    RES13

    Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée

    1 pagesCERT3

    Re-enregistrement de l'assentiment

    1 pagesFOA-RR

    Réenregistrement des statuts

    38 pagesMAR

    Re-enregistrement d'une société à responsabilité limitée privée en société à responsabilité illimitée privée

    1 pagesRR05

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    22 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 déc. 2015

    État du capital au 07 déc. 2015

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2015

    État du capital au 02 janv. 2015

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Cessation de la nomination de Stephen Walder en tant que directeur le 26 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Cynthia Russo en tant que directeur le 26 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Frank Peter Ward en tant que directeur le 26 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Walder en tant que secrétaire le 26 nov. 2014

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Kaweh Niroomand en tant que directeur le 26 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Oracle Corporation Nominees Limited en tant qu'administrateur le 26 nov. 2014

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr David James Hudson en tant qu'administrateur le 26 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 6-8 the Grove Slough Berkshire SL1 1QP à Oracle Parkway Thames Valley Park Reading Berkshire RG6 1RA le 01 déc. 2014

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2014

    État du capital au 02 janv. 2014

    • Capital: GBP 500,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    25 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ANKER SYSTEMS ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUDSON, David James
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    EnglandBritish100987010002
    ORACLE CORPORATION NOMINEES LIMITED
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03062158
    118326710001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Secrétaire
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Secrétaire
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secrétaire
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Secrétaire
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Other123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Secrétaire
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    British39173700002
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Secrétaire
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    British115960470001
    WALDER, Stephen
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    Secrétaire
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    British169959800001
    ABDO, Ashley
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    63 West Ranch Trail
    CO80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    American90157130001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Administrateur
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    APPLETON, Colin Arthur
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    15 The Coppice
    Cuddington
    CW8 2XF Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish19964370001
    BAILEY, James R
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    Administrateur
    1000 Rock Ridge Lane
    Loveland
    Colorado
    80537
    Usa
    American69700010001
    BAKER, Jeremy David
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    16 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British51244270001
    BUTCHER, Steve John
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203318870001
    CALLAGHAN, Stephen James
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    Administrateur
    The Grove
    SL1 1QP Slough
    6-8
    Berkshire
    EnglandBritish87418990003
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Administrateur
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New Zealander126903810001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    Administrateur
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New Zealander122786180001
    DOBIE, Timothy Arthur Ross
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    Administrateur
    1 St Andrews Road
    Brockhall Village Old Langho
    BB6 8BP Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish97704830001
    DOBSON, Melvyn John
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    Administrateur
    42 Ravens Wood
    Chorley New Road Heaton
    BL1 5TL Bolton
    British45852970001
    DURKIN, Ivan Paul
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    Administrateur
    11 Stapleford Close
    BL8 2UG Bury
    Lancashire
    British51244360001
    EARHART, Stephen
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Brittens Lane
    Salford
    MK17 8BE Milton Keynes
    1
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United States133153450001
    FOULKES, John Harold
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    British1657980007
    GILDART, Steven
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    Administrateur
    12 Ennerdale Road
    Astley Tyldesley
    M29 7AR Manchester
    British51244420001
    GILES, Peter Hardwick
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish35521860001
    GRADDEN, Amanda Jane
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    Administrateur
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    EnglandBritish77425910003
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Administrateur
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Canadian123427350001
    HAYES, Laurence
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    15 Heald Cottages
    Judith Street Lowerfold
    OL12 7HS Rochdale
    Lancashire
    British51244430001
    HIRANO, Michael
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    139 Eagle Canyon Circle
    PO BOX 1925
    CO80540 Lyons
    Colorado
    Usa
    American90157180001
    HOLLENBECK, David Arthur
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    5166 Buckingham Road
    CO80301 Boulder
    Colorado
    Usa
    American90157320001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Administrateur
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOther123425810001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish39173700002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ANKER SYSTEMS ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    06 avr. 2016
    Thames Valley Park
    RG6 1RA Reading
    Oracle Parkway
    Berkshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement6273940
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ANKER SYSTEMS a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 oct. 2009
    Livré le 02 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 02 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture (the "agreement")
    Créé le 28 janv. 2000
    Livré le 09 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Ag London Branchas Trustee for the Beneficiaries (As Defined Inschedule 1)
    Transactions
    • 09 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 août 1999
    Livré le 24 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of adherence
    Créé le 12 mai 1992
    Livré le 14 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13TH april 1992 the composite debenture dated 26TH april 1990 and any other security documents (as defined)
    Brèves mentions
    The charged assets as defined in the original charge see form 395 ref M563C.
    Personnes ayant droit
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transactions
    • 14 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second supplemental deed
    Créé le 12 mai 1992
    Livré le 14 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 or any other security document (as defined)
    Brèves mentions
    The charges and assignments contained inclause 2 of the original debenture DATED26 april 1990.
    Personnes ayant droit
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transactions
    • 14 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 13 avr. 1992
    Livré le 30 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from theriva group PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents as defined
    Brèves mentions
    See form 395 ref M90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank Plcmilneas Agent and Trustee for Itself the Banks and Mr
    Transactions
    • 30 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 12 août 1991
    Livré le 20 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility to the dated 23RD april 1990 and any other security document (as defined)
    Brèves mentions
    (See form 395- ref M135 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Fbg Holdings (U.K.) Limited
    Transactions
    • 20 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 13 mai 1991
    Livré le 29 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from riva group PLC to the chargee under each of the finance documents as defined
    Brèves mentions
    (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC.
    Transactions
    • 29 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantees & mortgage debenture
    Créé le 26 avr. 1990
    Livré le 08 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document
    Brèves mentions
    (See doc M228 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transactions
    • 08 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 nov. 1989
    Livré le 30 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined to the chargee.
    Brèves mentions
    All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property. (See form m 395 ref m 849C for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank Plcined)(As Agent for and on Behalf of the Banks, as Def
    Transactions
    • 30 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 sept. 1987
    Livré le 22 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £133,000.00 and all other monies due or to become due from the and alistair scott petrie and barbara ann petrie company to the chargee
    Brèves mentions
    1, the farthings, marcham abingdon, oxfordshire. T/n:- on 60470. and all fixtures thereon and additions thereto.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 janv. 1982
    Livré le 04 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed amd floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juin 1980
    Livré le 24 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 juin 1980Enregistrement d'une charge
    • 25 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0