LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED

LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01367545
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAIDSOUTH LIMITED10 mai 197810 mai 1978

    Quels sont les derniers comptes de LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 déc. 2020

    9 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 08 sept. 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 déc. 2019

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 déc. 2018

    9 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    8 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de 25 Gresham Street London EC2V 7HN à Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF le 25 janv. 2018

    2 pagesAD01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 25 Gresham Street London EC2V 7HN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 25 Gresham Street London EC2V 7HN

    2 pagesAD02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 déc. 2017

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew John Kemp en tant qu'administrateur le 09 janv. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Owen Williams en tant que directeur le 19 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michelle Antoinette Angela Johnson en tant que secrétaire le 23 mars 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 23 mars 2016

    2 pagesAP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2016

    État du capital au 02 mars 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    20 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Owen Williams le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritish152332230001
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    KEMP, Andrew John
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    4th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish222042280001
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    HATCHER, Michael Roger
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    Secrétaire
    Hunyani Ardleigh Road
    Little Bromley
    CO11 2QA Manningtree
    Essex
    British6759000002
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Secrétaire
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    178916390001
    MASLEN, Frederick Charles Archibald
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    Secrétaire
    69 Hayes Hill
    Hayes
    BR2 7HN Bromley
    Kent
    British3770350001
    SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs.
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Irish45487120004
    STAFFORD, Paul Andrew
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    Secrétaire
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    British48252270001
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02791894
    73512200003
    BASING, Anthony Mark
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    British99221710001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    Administrateur
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritish46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British32423210001
    DAVIES, John Thomas
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Hearn Close
    Tylers Green
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    British2501430001
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Administrateur
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British40761160001
    FULLELOVE, William Roy
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    Administrateur
    10 Ennismore Avenue
    GU1 1SP Guildford
    Surrey
    British46128130001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish152766650002
    GRANT, Mark Andrew
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    Administrateur
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    United KingdomBritish236442470001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    Administrateur
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritish141461000001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritish8949580001
    HERBERT, Jon Mark
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish203539400001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Administrateur
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JOSEPH, Michael William
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish44954410002
    KING, Roger Steuart
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    Administrateur
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    United States Citizen79713690002
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Administrateur
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Administrateur
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    MOORE, Alan Edward
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    Administrateur
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    British71480200001
    PELLY, Richard Fowler
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    Administrateur
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    EnglandBritish99868440002
    PRITCHARD, David Peter
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    Administrateur
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    EnglandBritish57244610001
    RIDING, Frederick Michael Peter
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    Administrateur
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    British76317830002
    SEGGINS, Roger Russell
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Marronwood 4 Kelvedon Avenue
    KT12 5ED Walton On Thames
    Surrey
    British46846030003
    TATE, George Truett
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    EnglandAmerican99804980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01004792
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed of general assignment
    Créé le 01 déc. 2003
    Livré le 05 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company; carolita shipping limited; allco finance (UK) limited; aus shipping LTD; allocean limited; or leif hoegh & co asa to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the right, title and interest, present and future, in, to and under a deed of general assignment dated 20 march 2000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 05 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of general assignment between the company, allco finance limited (the "general partner"), allco finance (UK) limited (the "sponsor") and carolita shipping limited (the "owner") in favour of lloyds tsb bank PLC in its capacity as security trustee for and on behalf of itself and certain other beneficiaries (the "security trustee")
    Créé le 20 mars 2000
    Livré le 03 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, liabilities and obligations due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with any documents from time to time designated as "transaction documents" by each of the general partner, the investor, the bank guarantor and uih
    Brèves mentions
    Right title and interest under a deed of general assignment, a time charter, a guarantee dated 20 march 2000, the benefit of the insurances in respect of the said vessel and any compensation.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security over shares agreement between lloyds bank PLC (as secured party) allco finance limited and the hual carolita limited partnership (together as chargors)
    Créé le 04 sept. 1998
    Livré le 22 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from allco finance (UK) limited (as obligor) to the chargees under the terms of the agreement and counter-indemnity of even date
    Brèves mentions
    1 (one) ordinary share in the share capital of carolita shipping limited issued and held by to the order to or on behalf of the chargor at any time together with all dividends interest and other monies arising therefrom under paragraph 4.1.1 of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC(As Security Trustee for Itself and the Beneficiaries)
    Transactions
    • 22 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of general assignment and covenant between the company (as investor), carolita shipping limited (as owner), allco finance limited (as general partner) allco finance (UK) limited (as sponsor) and lloyds bank PLC (as assignee)
    Créé le 04 sept. 1998
    Livré le 22 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each a "security party") to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the deed)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to a). The insurances b). Any requisition compensation c). All sums of money on or from the date of creation of the charge standing to the credit of an account and all related rights thereto and thereof d). The charterparty, the construction supervision agreement, the uih guarantee of charter and secondary put option and all claims rights and remedies of that assignor arising therefrom (inc. All damages and compensation payable) e). The novated shipbuilding contract and the novation agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC(As Security Chargee for Itself and the Beneficiaries)
    Transactions
    • 22 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    LLOYDS COMMERCIAL LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 déc. 2017Commencement of winding up
    02 sept. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0