NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01370566
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED ?

    • (2524) /

    Où se situe NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SWISH BUILDING PRODUCTS LIMITED 05 mars 199805 mars 1998
    BREVILLE EUROPE LIMITED31 déc. 197831 déc. 1978
    DROWLEN LIMITED25 mai 197825 mai 1978

    Quels sont les derniers comptes de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 sept. 2013

    6 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 sept. 2012

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Cessation de la nomination de Adrian Egerton Darling en tant que directeur le 31 mai 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jan-Feie Zwiers en tant qu'administrateur le 31 mai 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Leslie Nash en tant que directeur le 26 mars 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Mcfaull en tant que directeur le 26 mars 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Thomas Moss en tant qu'administrateur le 26 mars 2012

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2011

    État du capital au 27 oct. 2011

    • Capital: GBP 25,866,666.7
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Leslie Nash le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England le 27 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Leslie Nash le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 13 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    MOSS, Paul Thomas
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director167898270001
    ZWIERS, Jan-Feie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    NetherlandsDutchGroup Finance Controller169623550001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Secrétaire
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Secrétaire
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishGroup Finance Director13813980005
    DAVIES, Michael Thomas
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    Administrateur
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    BritishManager50770000002
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Administrateur
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant56562210001
    GODDARD, David Peter
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector8828350002
    HANRAHAN, Shaun Patrick
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    Administrateur
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    BritishCommercial Director49298590002
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    BritishFinancial Controller83628430003
    NASH, Robert Leslie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller83397580001
    PURCHASE, Roger
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director49298600001
    SIMPSON, Kenneth
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    BritishManaging Director27376570002
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    BritishChartered Secretary30601260018
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Créé le 05 déc. 2000
    Livré le 12 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 27 févr. 1998
    Livré le 16 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as therein defined) (or any of them) under each or any of the finance documents (as therein defined) on any account whatsoever provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that, if it were included, supplemental debenture or the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 16 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 09 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the finance parties or any of them under each or any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    Transactions
    • 09 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 janv. 2014Dissolved on
    27 sept. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0