A & L CF MARCH (3) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéA & L CF MARCH (3) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01371913
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de A & L CF MARCH (3) LIMITED ?

    • (7134) /

    Où se situe A & L CF MARCH (3) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Griffins Tavistock House South
    Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de A & L CF MARCH (3) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOVEREIGN RENTALS LIMITED21 juin 199321 juin 1993
    CATER ALLEN INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED29 avr. 198329 avr. 1983
    ALLEN HARVEY & ROSS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED05 juin 197805 juin 1978

    Quels sont les derniers comptes de A & L CF MARCH (3) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour A & L CF MARCH (3) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pages4.71

    Cessation de la nomination de Scott Linsley en tant que directeur le 07 oct. 2011

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 août 2011

    11 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Building 3 Floor 2 Carlton Park Narborough Leicester LE19 0AL le 26 août 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 août 2010

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Cessation de la nomination de Colin Morley en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martin Evans en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de David Martin Green en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Scott Linsley en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Shaun Patrick Coles en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 juil. 2010

    État du capital au 13 juil. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Richard Allen Hawker le 28 oct. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Richard Morley le 03 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Martin William Evans le 03 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Cessation de la nomination de William Paterson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    23 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de A & L CF MARCH (3) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAWKER, Richard Allen
    Narborough
    LE19 0AL Leicester
    Carlton Park
    Secrétaire
    Narborough
    LE19 0AL Leicester
    Carlton Park
    British78397850001
    COLES, Shaun Patrick
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    Administrateur
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United KingdomBritishCompany Secretary95706540001
    GREEN, David Martin
    2 Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    Abbey National House
    England
    Administrateur
    2 Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    Abbey National House
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant157202700001
    HEPPLEWHITE, Julian
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    Secrétaire
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    British51619950002
    SINCLAIR FORD, Ian Andrew
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    Secrétaire
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    British58189030001
    SULLIVAN, Terence Michael
    15 Chestnut Avenue
    CM12 9JF Billericay
    Essex
    Secrétaire
    15 Chestnut Avenue
    CM12 9JF Billericay
    Essex
    British11433910001
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Secrétaire
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    BritishChief Executive27312630001
    BARCLAY, James Christopher
    Rivers Hall
    Waldringfield
    IP12 4QX Woodbridge
    Suffolk
    Administrateur
    Rivers Hall
    Waldringfield
    IP12 4QX Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritishBanker6395690001
    DUFFY, Anthony Paul
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    Administrateur
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    EnglandBritishDeputy Md Girobank72286750001
    EVANS, Martin William
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    Administrateur
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    EnglandBritishAccountant55210060002
    JARDINE, John
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    Administrateur
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    BritishFinance House Dir31897840002
    JONES, Christopher Stanley
    Flat 34 Roberts Court
    45-49 Barkston Gardens Kensington
    SW5 0ES London
    Administrateur
    Flat 34 Roberts Court
    45-49 Barkston Gardens Kensington
    SW5 0ES London
    United KingdomBritishBanker152017480001
    LA ROCHE, Anthony Philip
    Woodlands Goat Lodge Road
    Great Totham
    CM9 8BX Maldon
    Essex
    Administrateur
    Woodlands Goat Lodge Road
    Great Totham
    CM9 8BX Maldon
    Essex
    BritishFinancial Futures Broker11534880001
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    Administrateur
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    United KingdomBritishFinance House Director73882180001
    LINSLEY, Scott
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    Administrateur
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United KingdomBritishCompany Secretary126009060001
    MARKS, Norman
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Administrateur
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    BritishFinance House Director48820520002
    MORLEY, Colin Richard
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    United Kingdom
    Administrateur
    Deansgate
    M3 4HH Manchester
    298
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant89102840002
    PATERSON, William Hamilton
    Laigh Brownmuir House
    Glassford
    ML10 6TX Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    Laigh Brownmuir House
    Glassford
    ML10 6TX Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritishBanker147129850001
    POUND, John Alan
    4 Tanglewood Close
    Shirley
    CR0 5HX Croydon
    Surrey
    Administrateur
    4 Tanglewood Close
    Shirley
    CR0 5HX Croydon
    Surrey
    United KingdomBritishBanker11814790001
    ROGERS, Malcolm Courtney
    2 Wheatley Royd Barn
    Brearley Lane Luddendenfoot
    HX2 6HX Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Wheatley Royd Barn
    Brearley Lane Luddendenfoot
    HX2 6HX Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishBanker72877280001
    SCOTT, Ian Garden
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishChief Executive79132120001
    SWANN, Andrew Blyth
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishBanker60626890003
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Administrateur
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    United KingdomBritishChief Executive27312630001
    TOWERS, Robert Leslie
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    Administrateur
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    United KingdomBritishBanker65275200002

    A & L CF MARCH (3) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 18 janv. 2006
    Livré le 27 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the ship m v clipper bordeaux registered under the british flag with official number 911093,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bordeaux Shipping Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenant
    Créé le 18 janv. 2006
    Livré le 27 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the ship m v clipper bordeaux registered under the british flag with official number 911093,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bordeaux Shipping Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenant
    Créé le 14 juin 2005
    Livré le 23 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The companys right title and interest in and to sixty four sixty fourth (64/64TH) shares in the ship being mv crescent beaune reg no 909360 and her equipment and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Beaune Shipping Limited
    Transactions
    • 23 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 14 juin 2005
    Livré le 23 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The companys right title and interest in and to sixty four sixty fourth (64/64TH) shares in the ship being mv crescent beaune reg no 909360 and her equipment and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Beaune Shipping Limited
    Transactions
    • 23 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    A & L CF MARCH (3) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 août 2010Commencement of winding up
    01 janv. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kevin Ashley Goldfarb
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    practitioner
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0