A & L CF MARCH (3) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | A & L CF MARCH (3) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01371913 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe A & L CF MARCH (3) LIMITED ?
Adresse du siège social | Griffins Tavistock House South Tavistock Square WC1H 9LG London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de A & L CF MARCH (3) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour A & L CF MARCH (3) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | 4.71 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Scott Linsley en tant que directeur le 07 oct. 2011 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 août 2011 | 11 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Building 3 Floor 2 Carlton Park Narborough Leicester LE19 0AL le 26 août 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Morley en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Evans en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de David Martin Green en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Scott Linsley en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Shaun Patrick Coles en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Richard Allen Hawker le 28 oct. 2009 | 3 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Richard Morley le 03 nov. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Martin William Evans le 03 nov. 2009 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Paterson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 23 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de A & L CF MARCH (3) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWKER, Richard Allen | Secrétaire | Narborough LE19 0AL Leicester Carlton Park | British | 78397850001 | ||||||
COLES, Shaun Patrick | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Company Secretary | 95706540001 | ||||
GREEN, David Martin | Administrateur | 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London Abbey National House England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 157202700001 | ||||
HEPPLEWHITE, Julian | Secrétaire | The Old Rectory Rectory End LE8 9EW Burton Overy Leicestershire | British | 51619950002 | ||||||
SINCLAIR FORD, Ian Andrew | Secrétaire | Stainton 103 Menlove Avenue Calderstones L18 3HP Liverpool | British | 58189030001 | ||||||
SULLIVAN, Terence Michael | Secrétaire | 15 Chestnut Avenue CM12 9JF Billericay Essex | British | 11433910001 | ||||||
TAYLOR, Charles Stuart | Secrétaire | Balnacroft 8 Stonewalls Rosemary Lane Rossett LL12 0LG Wrexham Flintshire | British | Chief Executive | 27312630001 | |||||
BARCLAY, James Christopher | Administrateur | Rivers Hall Waldringfield IP12 4QX Woodbridge Suffolk | United Kingdom | British | Banker | 6395690001 | ||||
DUFFY, Anthony Paul | Administrateur | 7 Outram Road Alexandra Park N22 7AB London | England | British | Deputy Md Girobank | 72286750001 | ||||
EVANS, Martin William | Administrateur | Deansgate M3 4HH Manchester 298 | England | British | Accountant | 55210060002 | ||||
JARDINE, John | Administrateur | The Old School Guilden Sutton Lane Guilden Sutton CH3 7EX Chester | British | Finance House Dir | 31897840002 | |||||
JONES, Christopher Stanley | Administrateur | Flat 34 Roberts Court 45-49 Barkston Gardens Kensington SW5 0ES London | United Kingdom | British | Banker | 152017480001 | ||||
LA ROCHE, Anthony Philip | Administrateur | Woodlands Goat Lodge Road Great Totham CM9 8BX Maldon Essex | British | Financial Futures Broker | 11534880001 | |||||
LEE, Andrew Philip, Mr. | Administrateur | 29 Alder Lane Balsall Common CV7 7DZ Solihull | United Kingdom | British | Finance House Director | 73882180001 | ||||
LINSLEY, Scott | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | Company Secretary | 126009060001 | ||||
MARKS, Norman | Administrateur | 4 Old Hall Park Guilden Sutton CH3 7ER Chester | British | Finance House Director | 48820520002 | |||||
MORLEY, Colin Richard | Administrateur | Deansgate M3 4HH Manchester 298 United Kingdom | England | British | Accountant | 89102840002 | ||||
PATERSON, William Hamilton | Administrateur | Laigh Brownmuir House Glassford ML10 6TX Strathaven Lanarkshire | Scotland | British | Banker | 147129850001 | ||||
POUND, John Alan | Administrateur | 4 Tanglewood Close Shirley CR0 5HX Croydon Surrey | United Kingdom | British | Banker | 11814790001 | ||||
ROGERS, Malcolm Courtney | Administrateur | 2 Wheatley Royd Barn Brearley Lane Luddendenfoot HX2 6HX Halifax West Yorkshire | England | British | Banker | 72877280001 | ||||
SCOTT, Ian Garden | Administrateur | Riverbank House AB34 5JD Aboyne Aberdeenshire | Scotland | British | Chief Executive | 79132120001 | ||||
SWANN, Andrew Blyth | Administrateur | Nield House Beamond End HP7 0QT Amersham Buckinghamshire | England | British | Banker | 60626890003 | ||||
TAYLOR, Charles Stuart | Administrateur | Balnacroft 8 Stonewalls Rosemary Lane Rossett LL12 0LG Wrexham Flintshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 27312630001 | ||||
TOWERS, Robert Leslie | Administrateur | 27 Winwick Park Avenue Winwick WA2 8XB Warrington | United Kingdom | British | Banker | 65275200002 |
A & L CF MARCH (3) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 18 janv. 2006 Livré le 27 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in the ship m v clipper bordeaux registered under the british flag with official number 911093,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of covenant | Créé le 18 janv. 2006 Livré le 27 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in the ship m v clipper bordeaux registered under the british flag with official number 911093,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of covenant | Créé le 14 juin 2005 Livré le 23 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The companys right title and interest in and to sixty four sixty fourth (64/64TH) shares in the ship being mv crescent beaune reg no 909360 and her equipment and appurtenances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 14 juin 2005 Livré le 23 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The companys right title and interest in and to sixty four sixty fourth (64/64TH) shares in the ship being mv crescent beaune reg no 909360 and her equipment and appurtenances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
A & L CF MARCH (3) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0