ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALPHA BOURNEMOUTH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01376794
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vertu House Fifth Avenue Business Park
    Team Valley
    NE11 0XA Gateshead
    Tyne And Wear
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRISTOL STREET BOURNEMOUTH LIMITED01 mars 199501 mars 1995
    JESSUPS (HODDESDON) LIMITED24 juil. 198924 juil. 1989
    INCHMEAD LIMITED04 juil. 197804 juil. 1978

    Quels sont les derniers comptes de ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Changement d'adresse du siège social de Vertu House Kingsway North Team Valley Gateshead Tyne and Wear NE11 0JH à Vertu House Fifth Avenue Business Park Team Valley Gateshead Tyne and Wear NE11 0XA le 12 avr. 2016

    2 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de * Rotterdam House 116 Quayside Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 3DY* le 06 avr. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination de Muckle Secretary Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de * Watchmoor Point Watchmoor Road Camberley Surrey GU15 3EX* le 14 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Britax International Services Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    miscellaneous

    Résolutions

    Resmisc- variation order
    RESMISC

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    2 pages88(2)R

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04

    legacy

    1 pages123

    legacy

    5 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2000

    1 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MUCKLE SECRETARY LIMITED
    c/o Muckle Llp
    23 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    c/o Muckle Llp
    23 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne & Wear
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5276019
    101749170003
    ANDERSON, Karen
    Town Farm House
    Ryton Village
    NE40 3QQ Ryton
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Town Farm House
    Ryton Village
    NE40 3QQ Ryton
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishFinance Director118122030001
    GANNEY, John Roy
    Swan House 29 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SH Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Swan House 29 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SH Colchester
    Essex
    British3379850001
    BRITAX INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    Secrétaire
    Seton House
    Warwick Technology Park Gallows Hill
    CV34 6DE Warwick
    109290004
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Administrateur
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Hook End Barn Bellemere Road
    Hampton-In-Arden
    B92 0AN Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Hook End Barn Bellemere Road
    Hampton-In-Arden
    B92 0AN Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director24487000001
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Administrateur
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    GANNEY, John Roy
    Swan House 29 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SH Colchester
    Essex
    Administrateur
    Swan House 29 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SH Colchester
    Essex
    BritishCompany Director/Secretary3379850001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director116885790001
    JOSEPH, Ronald Lionel
    Greenlees
    Gardiners Lane North Grays Hill
    CM11 2XA Billericay
    Essex
    Administrateur
    Greenlees
    Gardiners Lane North Grays Hill
    CM11 2XA Billericay
    Essex
    BritishCompany Director3379870001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director34653220001
    SMITH, Lionel Leslie Gordon
    10 Barrow View
    BH22 9SY Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    10 Barrow View
    BH22 9SY Ferndown
    Dorset
    BritishDirector44701370003
    STRONG, Peter Edwin
    Glebe Cottage
    Rectory Road
    DT2 7TE Piddlehinton
    Dorset
    Administrateur
    Glebe Cottage
    Rectory Road
    DT2 7TE Piddlehinton
    Dorset
    BritishManaging Director63671740001
    THOMPSON, Stanley George
    26 Manor Links
    CM23 5RA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    26 Manor Links
    CM23 5RA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director3653930001
    THOMSON, William Norman
    Hyde Cottage
    Great Saling
    CM7 5EW Braintree
    Essex
    Administrateur
    Hyde Cottage
    Great Saling
    CM7 5EW Braintree
    Essex
    BritishSales Director3611450001
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant2756010001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant41591930001
    TUSTAIN, John Bernard
    Clattercut Lane
    Rushock
    WR9 0NN Droitwich
    The Old Oak Barn
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Clattercut Lane
    Rushock
    WR9 0NN Droitwich
    The Old Oak Barn
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector128982570002
    WILLIAMS, Paul Raymond
    Summerfields House
    Stoke Pound Lane Stoke Prior
    B60 4LE Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    Summerfields House
    Stoke Pound Lane Stoke Prior
    B60 4LE Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishDirector15080230001

    ALPHA BOURNEMOUTH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land on the south west side of castle lane bournemouth BH9 3JS with all fixtures and fittings t/n DT120497. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land on the south side of hawthorn road bournemouth dorset with all fixtures and fittings t/n DT165062. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land at the rear of 694 wimborne road winton bournemouth dorset t/n DT151785 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The premises on the south west side of castle lane west bournemouth dorset t/n DT120497 with all buildings and fixtures and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The premises on the south side of hamthorn road bournemouth dorset t/n DT165062 with all buildings fixtures and fittings and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The premises at the rear of 694 wimborne road winton bournemouth dorset t/n DT151785 with all buildings and all fixtures and fittings and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 1993
    Livré le 06 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All those monies owing to jessups (hoddesdon) limited by saab great britain limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Saab Finance Limited
    Transactions
    • 06 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Used vehicle charge
    Créé le 16 févr. 1993
    Livré le 22 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All interest (if any) in any used cars ,unused vehicles and vehicles which have been used only for the purpose of delivery see form 395 M4 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale Limited
    Transactions
    • 22 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 mai 1992
    Livré le 28 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a premises on the south side of eleanor cross road waltham cross cheshunt hertfordshire with all buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 28 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 30 avr. 1992
    Livré le 01 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge goodwill with all book debts and other debts of the company floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 01 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 avr. 1992
    Livré le 09 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H premises on southside of eleanor cross road waltham cross cheshunt hertfordshire together with all fixtures and fittings and the benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 06 août 1991
    Livré le 07 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    4
    Brèves mentions
    By way of fixed and specific charge all the book debts of the dealer present and future arising from the sale lease or other disposal of trucks and vehicles of all descriptions together with all all securities held by the dealer with the payment of all principal costs charges and expenses payable by the dealer hereunder.
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale Limited
    Transactions
    • 07 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 juin 1991
    Livré le 04 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 août 1988
    Livré le 07 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    21 high street hoddesdon hertfordshire t/n hd 113206.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 22 août 1988
    Livré le 31 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 24 nov. 1986
    Livré le 27 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Used motor vehicles and all the interest of the company is such motor vehicles.
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transactions
    • 27 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 10 avr. 1986
    Livré le 15 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & specific charge (1) all the stock of new /used trucks & vehicles now owned or which the dealer has an interest. (2) floating charge over the book debts, stock in trade. (See doc M14 for details).
    Personnes ayant droit
    • Psa Wholesale Limited
    Transactions
    • 15 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 14 janv. 1983
    Livré le 18 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of as consignment agreement d/d 14/1/83.
    Brèves mentions
    All that the mortgagor's interest many vehicle delivered to it under the terms of the serial consignment agreement and any moneys received therefor.
    Personnes ayant droit
    • Talbot Wholesale Limited
    Transactions
    • 18 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 sept. 1982
    Livré le 11 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H lands, hereditaments and premises being:- 21 high street, hoddesdon, herts. T.N. hd 113206.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 02 mai 1981
    Livré le 20 mai 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 1981Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 08 août 1980
    Livré le 09 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All those monies which from time to time be owing to inchmead LTD by volkswagon (GB) LTD (see doc M10 for details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds & Scottish Trust LTD
    Transactions
    • 09 août 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0