HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED

HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 01377801
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOUSE OF TRAVEL (WALES) LIMITED19 juin 199219 juin 1992
    C T C TOURS (WALES) LTD31 déc. 198131 déc. 1981
    COLLEGE TRANSPORT (GWENT) LIMITED10 juil. 197810 juil. 1978

    Quels sont les derniers comptes de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Forms b & z convert to rs
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 28/07/2016
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed house of travel (wales) LIMITED\certificate issued on 22/07/16
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    État du capital après une attribution d'actions au 08 juin 2016

    • Capital: GBP 319,564
    3 pagesSH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2015

    État du capital au 02 sept. 2015

    • Capital: GBP 319,562
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2014

    État du capital au 02 sept. 2014

    • Capital: GBP 319,562
    SH01

    Cessation de la nomination de Patrick Moynihan en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Paul Lang en tant qu'administrateur le 30 juin 2014

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 sept. 2013

    État du capital au 04 sept. 2013

    • Capital: GBP 319,562
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Moynihan le 01 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cws (No.1) Limited le 01 sept. 2013

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Caroline Jane Sellers le 01 sept. 2013

    2 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2013

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * New Century House Manchester M60 4ES* le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    British45801060004
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1925625
    130695310001
    BELL LANGFORD, Diana Beverley
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British38495160002
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    WRIGHT, Wiliam Thomas
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British26223750001
    BELL LANGFORD, David James
    1 Cae Pen Y Graig
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    1 Cae Pen Y Graig
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British67740010001
    BELL LANGFORD, Diana Beverley
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    1 Cae Pen Y Craig
    Energlyn Parc
    CF83 2AD Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British38495160002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Administrateur
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    COOMBS, Clive
    19 Ely Street
    CF40 1BY Tonypandy
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    19 Ely Street
    CF40 1BY Tonypandy
    Mid Glamorgan
    British24868440001
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Administrateur
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritish74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Administrateur
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritish188221460001
    MCPHERSON, Kenneth
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish224051820001
    MELLING, Christopher Eric
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish58695390001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritish87719730001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    British80173660001
    RANKIN, Yvonne Rose
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    Administrateur
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    British107621540001
    SCOTT, Maurice
    39 Woodland Park
    OL2 5UY Royton
    Lancashire
    Administrateur
    39 Woodland Park
    OL2 5UY Royton
    Lancashire
    EnglandBritish107500770001
    WILLIAMS, Amanda Jane
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    Administrateur
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    British87240350002
    WRIGHT, Wiliam Thomas
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Cwmleyshon Cottage
    Rudry
    CF8 3EB Caerphilly
    Mid Glamorgan
    British26223750001

    HOUSE OF TRAVEL (2016) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 13 déc. 2000
    Livré le 20 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    197 high street treorchy rhondda cynon taf t/n WA712653.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 déc. 2000
    Livré le 20 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    53 hannah st,porth,rhondda cynon taf; t/no WA135149.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 12 mai 1998
    Livré le 22 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    21 oxford street mountain ash mid glamorgan.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 nov. 1997
    Livré le 13 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    25 beaufort street brynmawr gwent t/no.WA502437.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 août 1996
    Livré le 03 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    121A dunraven street tonypandy rhondda cynon taff t/n WA793892.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 oct. 1995
    Livré le 10 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 29 mars 1994
    Livré le 15 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £16,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property at 197 high street treorchy mid glamorgan.
    Personnes ayant droit
    • Alan Roderick Hawkins
    Transactions
    • 15 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 déc. 1988
    Livré le 29 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 1985
    Livré le 02 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0