DIODES ZETEX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDIODES ZETEX LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01378777
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DIODES ZETEX LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DIODES ZETEX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Zetex Technology Park
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DIODES ZETEX LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ZETEX LIMITED09 juin 200809 juin 2008
    ZETEX PLC23 avr. 200423 avr. 2004
    TELEMETRIX PLC17 juil. 197817 juil. 1978

    Quels sont les derniers comptes de DIODES ZETEX LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DIODES ZETEX LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au11 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation25 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au11 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour DIODES ZETEX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Dr Gerard John Mccarthy en tant qu'administrateur le 01 févr. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Monaghan en tant que directeur le 02 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 013787770012, créée le 26 mai 2023

    57 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Julie Ann Holland en tant que directeur le 20 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 013787770011, créée le 01 févr. 2022

    57 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 013787770010, créée le 31 déc. 2020

    56 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Hans Rohrer en tant que directeur le 30 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 013787770009, créée le 29 mai 2020

    55 pagesMR01

    Nomination de Mrs Julie Ann Holland en tant qu'administrateur le 09 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Keh-Shew Lu en tant que directeur le 09 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    85 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Credit agreement finance documents 08/01/2013
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    20 pagesAA

    Nomination de Mr Brett Whitmire en tant qu'administrateur le 23 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Dallas White en tant que directeur le 23 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de DIODES ZETEX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCARTHY, Gerard John, Dr
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    Lancashire
    Administrateur
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    Lancashire
    ScotlandBritishEu President76685410002
    WHITMIRE, Brett
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    Lancashire
    Administrateur
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    Lancashire
    United StatesAmericanCfo260626430001
    GREENE, Colin Keith
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    BritishDirector59710770001
    MORTON, Julia Alison
    Kingsdown Close
    Wychwood Park
    CW2 5FX Weston
    5
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingsdown Close
    Wychwood Park
    CW2 5FX Weston
    5
    Cheshire
    United Kingdom
    British135499480001
    SEFTON, Michael Edward
    Oak Cottage Cuckoos Knob
    Wootton Rivers
    SN8 4NR Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    Oak Cottage Cuckoos Knob
    Wootton Rivers
    SN8 4NR Marlborough
    Wiltshire
    British51018120001
    SHARP, Lorraine
    168 Ember Lane
    KT10 8EJ Esher
    Surrey
    Secrétaire
    168 Ember Lane
    KT10 8EJ Esher
    Surrey
    BritishCompany Secretary26356800001
    AIREY, Elisabeth Patricia
    20 St Jamess Walk
    EC1R 0AP London
    Administrateur
    20 St Jamess Walk
    EC1R 0AP London
    EnglandBritishCompany Director107419680001
    CONWAY, Robert David
    10 Harrop Green
    Diggle
    OL3 5LW Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    10 Harrop Green
    Diggle
    OL3 5LW Oldham
    Lancashire
    BritishDirector34979860003
    COTTERILL, Roy Clifford George
    102 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    102 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector/Engineer1540920001
    CURTIS, Timothy Malise
    Street Farmhouse
    Vernham Street
    SP11 0EL Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Street Farmhouse
    Vernham Street
    SP11 0EL Andover
    Hampshire
    BritishAccountant/Director10381640015
    DELACAVE, Jacques Theodore Louis
    Flat N 56 Warwick Square
    SW1V 2AJ London
    Administrateur
    Flat N 56 Warwick Square
    SW1V 2AJ London
    BelgianDirector35533340001
    GARDENER, William Kenneth
    15 Ennismore Mews
    SW7 1AP London
    Administrateur
    15 Ennismore Mews
    SW7 1AP London
    BritishChartered Accountant38703010001
    GASKELL, Colin Simister
    Sequoia Lodge
    Oakhurst Avenue
    AL5 2ND Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Sequoia Lodge
    Oakhurst Avenue
    AL5 2ND Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director6837370002
    GEH, Martin Thein E
    16a Lornie Road
    FOREIGN Singapore
    298702
    Singapore
    Administrateur
    16a Lornie Road
    FOREIGN Singapore
    298702
    Singapore
    MalaysianDirector100994990002
    GREENE, Colin Keith
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    Administrateur
    15 Rippon Hall Avenue
    Ramsbottom
    BL0 9RE Bury
    Lancashire
    EnglandBritishDirector59710770001
    HAWKINS, Nick Bryan
    2 Weaver Close
    WA14 3FY Bowdon
    Cheshire
    Administrateur
    2 Weaver Close
    WA14 3FY Bowdon
    Cheshire
    BritishAccountant112132820001
    HOLLAND, Julie Ann
    Hedgecoxe Road
    Suite 100
    75024 Plano
    4949
    Texas
    United States
    Administrateur
    Hedgecoxe Road
    Suite 100
    75024 Plano
    4949
    Texas
    United States
    United StatesAmericanDirector260609390001
    KING, Mark
    Kilburn Ct
    Oak Park
    4984
    California 91377
    United States Of America
    Administrateur
    Kilburn Ct
    Oak Park
    4984
    California 91377
    United States Of America
    UsaAmericanDirector131421320001
    LU, Keh-Shew, Dr
    5109 Runnin River Drive
    Plano
    Texas 75093
    United States
    Administrateur
    5109 Runnin River Drive
    Plano
    Texas 75093
    United States
    United StatesAmericanDirector126068550001
    MONAGHAN, Timothy
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    Lancashire
    Administrateur
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    Lancashire
    United KingdomBritishEuropean General Manager242363600001
    NORTON, Michael James, Professor
    179b Kimbolton Road
    MK41 8DR Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    179b Kimbolton Road
    MK41 8DR Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomUnited KingdomChartered Engineer60051200001
    RATTRAY, Bruce Davidson
    The Little House 34 Parkway
    GU15 2PE Camberley
    Surrey
    Administrateur
    The Little House 34 Parkway
    GU15 2PE Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant3071690001
    ROCHUSSEN, Gavin Mark
    41 Fifth Avenue
    Illoso Johannesburg
    South Africa
    Administrateur
    41 Fifth Avenue
    Illoso Johannesburg
    South Africa
    South AfricanDirector68722730001
    ROHRER, Hans
    Senserbergstr
    82256 Fuerstenfeldbruck
    11a
    Germany
    Administrateur
    Senserbergstr
    82256 Fuerstenfeldbruck
    11a
    Germany
    EnglandGermanDirector106700130001
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant3909060002
    SAYERS, John William Cornelius
    18 Nel Avenue
    Randpark Ridge
    Republic Of South Africa 2156
    Administrateur
    18 Nel Avenue
    Randpark Ridge
    Republic Of South Africa 2156
    South AfricanChartered Accountant54381750001
    SNEDDEN, Donald Cameron
    The Gables
    108a Kloof Road
    FOREIGN Bedfordview 2008
    South Africa
    Administrateur
    The Gables
    108a Kloof Road
    FOREIGN Bedfordview 2008
    South Africa
    BritishChartered Accountant12659690001
    STRIDE, Charles Arthur
    60 Fourth Street
    Houghton 2198
    FOREIGN Johannesburg 2198
    South Africa
    Administrateur
    60 Fourth Street
    Houghton 2198
    FOREIGN Johannesburg 2198
    South Africa
    South AfricanAccountant/Director29455600001
    VENTER, Robert Eben
    3 Palala Road
    Westcliff 2193
    FOREIGN Johannesburg Gauteng
    Republic Of South Africa
    Administrateur
    3 Palala Road
    Westcliff 2193
    FOREIGN Johannesburg Gauteng
    Republic Of South Africa
    South AfricaSouth AfricanChief Executive & Director34889420003
    VENTER, William Peter, Doctor
    167 Empire Placead
    Sandhurst Sandton 2196
    FOREIGN Johannesburg
    Republic Of South Africa
    Administrateur
    167 Empire Placead
    Sandhurst Sandton 2196
    FOREIGN Johannesburg
    Republic Of South Africa
    South AfricanDirector38341820002
    WAITE, Barry
    1400 Rockcliff Road
    Austin
    Texas 78746
    Usa
    Administrateur
    1400 Rockcliff Road
    Austin
    Texas 78746
    Usa
    BritishDirector91507130001
    WALSH, Arthur Stephen
    Aiglemont
    Trout Rise Loudwater
    WD3 Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Aiglemont
    Trout Rise Loudwater
    WD3 Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Executive9663040001
    WHITE, Richard Dallas
    Twin Coves Street
    Dallas
    5907
    Texas 75248
    United States
    Administrateur
    Twin Coves Street
    Dallas
    5907
    Texas 75248
    United States
    United StatesAmericanDirector132081680001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DIODES ZETEX LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bentfield Industrial Units, Stockfield Road
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    England
    06 avr. 2016
    Bentfield Industrial Units, Stockfield Road
    Chadderton
    OL9 9LL Oldham
    Zetex Technology Park
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06475363
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DIODES ZETEX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2023
    Livré le 02 juin 2023
    En cours
    Brève description
    All present and future intellectual property rights including, but not limited to, class: 09, registered trademark: intellifet - united kingdom, expiry date: continuing indefinitely until renewal fee not paid for termination, registration number: 2337239, pursuant to clause 3 and as further described in schedule 2 part 1 of the accompanying copy instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 02 juin 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 févr. 2022
    Livré le 07 févr. 2022
    En cours
    Brève description
    All present and future intellectual property rights including, but not limited to, registered trademark intellifet - united kingdom, continuing indefinitely until renewal fee not paid for termination, registration number 2337239, pursuant to clause 3 and as further described in schedule 2 part 1 of the accompanying copy instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 07 févr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 déc. 2020
    Livré le 06 janv. 2021
    En cours
    Brève description
    All present and future registered intellectual property rights including, but not limited to, registered trademark: class 09, details: intellifet - united kingdom, expiry date: continuing indefinitely until renewal fee not paid for termination, registration no/document 2337239 pursuant to clause 3 and as further described in schedule 2, part 1 of the accompanying copy instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 06 janv. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 mai 2020
    Livré le 05 juin 2020
    En cours
    Brève description
    All the present and future registered intellectual property rights pursuant to clause 3 and as further described in schedule 2 of the accompanying copy instrument including, but not limited to, registered trademark - registration number/document: 7164032, class: 09, details: zetex mark - china, expiry date: continuing indefinitely until renewal fee not paid for termination.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 05 juin 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    Composite debenture
    Créé le 08 janv. 2013
    Livré le 16 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and assets present and future, including deposits, investments and related rights, goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of America, N.A.
    Transactions
    • 16 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 04 sept. 1986
    Livré le 22 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as land on the N.side of ashchurch road newtown, ashchurch, glouc. And the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 26 mars 1986
    Livré le 08 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all freehold or leasehold properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts a fixed and floating charge. A charge by way of legal mortgage over the properties. 1) f/h known as 1.96 acres at ashchurch industrial estate gloucestershire, and the proceeds of sale thereof. 2) f/h shannon way technology park, ashchurch road, gloucestershire and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 juin 1985
    Livré le 19 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1.96 acres of land at ashchurch industrial estate, tewkesbury, gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1985Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 07 févr. 1985
    Livré le 13 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 28 janv. 1983
    Livré le 03 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 avr. 1982
    Livré le 22 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or westward micro systems limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 1982
    Livré le 22 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 1.96 acres of land at ashchurch industrial estate, gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0