QBE RE (EUROPE) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | QBE RE (EUROPE) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Converti ou fermé |
| Numéro de société | 01378853 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe QBE RE (EUROPE) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de QBE RE (EUROPE) LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 déc. 2018 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2019 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour QBE RE (EUROPE) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Confirmation of transfer of assets and liabilities | 1 pages | MISC | ||||||||||
Divers Notification from overseas registry of completion of merger | 1 pages | MISC | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Wyn Parry en tant que directeur le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wai-Fong Au en tant que directeur le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart William Sinclair en tant que directeur le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Divers CB01 - cross border merger notice | 42 pages | MISC | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Graham Mccaig le 27 avr. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Graham Mccaig le 27 avr. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 49 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 46 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Qbe Holdings (Eo) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Nomination de Alexandra Jane Smith en tant que secrétaire le 26 juin 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Esther Felton Smith en tant que secrétaire le 26 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Nigel Joseph Douty Terry en tant qu'administrateur le 19 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Andrew Dodridge en tant que directeur le 19 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Graham Mccaig le 19 juil. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 45 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Joe Gordon en tant que directeur le 29 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic John Clayden en tant que directeur le 29 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jan Leflot en tant que directeur le 29 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian David Beckerson en tant que directeur le 29 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de QBE RE (EUROPE) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Alexandra Jane | Secrétaire | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | 234579550001 | |||||||
| INGRAM, Timothy Charles William | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 213011270001 | |||||
| MCCAIG, Malcolm Graham | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | England | British | 141026580004 | |||||
| PRYCE, Richard Vaughan | Administrateur | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | United Kingdom | British | 67199680002 | |||||
| TERRY, Nigel Joseph Douty | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 220136600001 | |||||
| WINKETT, David James | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 73175560004 | |||||
| BOLAND, Sharon Maria | Secrétaire | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | British | 60727940002 | ||||||
| DONOVAN, Peter William | Secrétaire | 6 Oldfield Close BR1 2LL Bromley Kent | British | 56232250001 | ||||||
| FELTON SMITH, Esther | Secrétaire | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | 199284840001 | |||||||
| GREENHALGH, Mary Denise | Secrétaire | 61 Alexandra Road TW9 2BT Kew Surrey | British | 42172510001 | ||||||
| MACGREGOR, Richard James | Secrétaire | 14 Cheyne Avenue South Woodford E18 2DR London | British | 83245460001 | ||||||
| PALLOT, Hugh Glen | Secrétaire | 143 Gresham Road TW18 2AG Staines Middlesex | British | 14485660002 | ||||||
| WILLIAMS, Adrian Charles Harold | Secrétaire | The Upper Flat 94 Offord Road N1 1PF London | British | 103327620002 | ||||||
| ANGST, Kurt | Administrateur | Lussirainstrasse 55 FOREIGN 6300 Zug Switzerland | Swiss | 13680770001 | ||||||
| AU, Wai-Fong | Administrateur | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | England | British | 124364220001 | |||||
| BECKERSON, Ian David | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 73004250005 | |||||
| BOGHE, Luc | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | Belgium | Belgian | 172508490001 | |||||
| BOWER, Martin Andrew | Administrateur | 33 Burns Avenue SS13 3AG Basildon Essex | British | 23307030001 | ||||||
| BURNS, Steven Paul | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 18761850004 | |||||
| CALLAHAN, John Donald | Administrateur | No 2 The Landmark FOREIGN Northfield Illinois 60093 Usa | Usa By Birth | 13680780001 | ||||||
| CLAYDEN, Dominic John | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | England | British | 183858000002 | |||||
| COTTERILL, Brian Raymond | Administrateur | Apartment 1305 Orchard Parksuites 11 Orchard Turn FOREIGN Singapore 23880 Singapore | Australian | 57508210004 | ||||||
| CURTIS, Cheryl Karen | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 166056480001 | |||||
| DODRIDGE, Philip Andrew | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 117364550002 | |||||
| DONOVAN, Peter William | Administrateur | 6 Oldfield Close BR1 2LL Bromley Kent | United Kingdom | British | 56232250001 | |||||
| DRABSCH, Neil Gregory | Administrateur | 26 Wyong Road Mosman Sydney 2088 FOREIGN Nsw Australia | Australian | 57323210001 | ||||||
| FABER, Robert Thomas | Administrateur | 307 Churchill Court Sleepy Hollow Illinois 60118 United States | Us Citizen | 39520250001 | ||||||
| FOGARTY, Desmond | Administrateur | 1 St Andrews Curragha Ashbourne Co Meath Ireland | Irish | 79250160001 | ||||||
| GLEN, Paul Edward | Administrateur | Marlands Court Itchingfield RH13 0NN Horsham West Sussex | British | 43947920002 | ||||||
| GORDON, Joe | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | England | British | 182302840001 | |||||
| GRANT, Robert Michael | Administrateur | Betsoms Hill The Avenue TN16 2EE Westerham Kent | British | 70624210001 | ||||||
| GROVE, Peter Ernest | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 4807730002 | |||||
| GROVE, Peter Ernest | Administrateur | Plantation Place 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London | United Kingdom | British | 4807730002 | |||||
| HEDIEN, Wayne Evans | Administrateur | 2531 Shannon Road FOREIGN Northbrook Illinois 60062 Usa | Usa By Birth | 13680740001 | ||||||
| HORGAN, Paul Liam | Administrateur | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | United Kingdom | British | 172495500001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QBE RE (EUROPE) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qbe Holdings (Eo) Limited | 06 avr. 2016 | 30 Fenchurch Street EC3M 3BD London Plantation Place United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
QBE RE (EUROPE) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Créé le 13 oct. 1998 Livré le 16 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti Any and all oligations of the company to the chargee under the security agreement or under any agreement | |
Brèves mentions The "charged portfolio" meaning all the company's right title and interest in all securities held to the order for the account or under the control or direction of the bank in account number 6-411604-001 all securities held by any clearance system on behalf of or for the bank in the account numbered euroclear 20419 and cedel 35254 and all rights benefits and proceeds and sums of money for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Reinsurance deposit agreement | Créé le 27 juin 1988 Livré le 29 juin 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 27.6.88. | |
Brèves mentions All monies at the date of the reinsurance deposit agreement see 395 (M93) for details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 27 juin 1988 Livré le 29 juin 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the security agreement dated 27/6/88 | |
Brèves mentions Seeform 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of hypothecation | Créé le 20 déc. 1985 Livré le 08 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All bullion coinbills of exchange & other negotiable instruments & all bills of lading warrants & other documents of title to goods, debentures bonds stocks etc (see M45). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0