QBE RE (EUROPE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQBE RE (EUROPE) LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 01378853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    QBE REINSURANCE (UK) LIMITED15 nov. 199615 nov. 1996
    ALLSTATE REINSURANCE CO. LIMITED23 nov. 198223 nov. 1982
    ALLSTATE REINSURANCE CO. (U.K.) LIMITED17 juil. 197817 juil. 1978

    Quels sont les derniers comptes de QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 déc. 2018
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 pagesMISC

    Divers

    Notification from overseas registry of completion of merger
    1 pagesMISC

    Cessation de la nomination de Jonathan Wyn Parry en tant que directeur le 31 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Wai-Fong Au en tant que directeur le 31 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stuart William Sinclair en tant que directeur le 31 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Divers

    CB01 - cross border merger notice
    42 pagesMISC

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Graham Mccaig le 27 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Graham Mccaig le 27 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    49 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    46 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Qbe Holdings (Eo) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Nomination de Alexandra Jane Smith en tant que secrétaire le 26 juin 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Esther Felton Smith en tant que secrétaire le 26 juin 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Nigel Joseph Douty Terry en tant qu'administrateur le 19 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Andrew Dodridge en tant que directeur le 19 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Malcolm Graham Mccaig le 19 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2016

    État du capital au 11 juil. 2016

    • Capital: GBP 20,082,852
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    45 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 juil. 2015

    État du capital au 22 juil. 2015

    • Capital: GBP 20,082,852
    SH01

    Cessation de la nomination de Joe Gordon en tant que directeur le 29 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dominic John Clayden en tant que directeur le 29 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jan Leflot en tant que directeur le 29 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian David Beckerson en tant que directeur le 29 juin 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Alexandra Jane
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Secrétaire
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    234579550001
    INGRAM, Timothy Charles William
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish213011270001
    MCCAIG, Malcolm Graham
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    EnglandBritish141026580004
    PRYCE, Richard Vaughan
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    Administrateur
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish67199680002
    TERRY, Nigel Joseph Douty
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish220136600001
    WINKETT, David James
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish73175560004
    BOLAND, Sharon Maria
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Secrétaire
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    British60727940002
    DONOVAN, Peter William
    6 Oldfield Close
    BR1 2LL Bromley
    Kent
    Secrétaire
    6 Oldfield Close
    BR1 2LL Bromley
    Kent
    British56232250001
    FELTON SMITH, Esther
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    Secrétaire
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    199284840001
    GREENHALGH, Mary Denise
    61 Alexandra Road
    TW9 2BT Kew
    Surrey
    Secrétaire
    61 Alexandra Road
    TW9 2BT Kew
    Surrey
    British42172510001
    MACGREGOR, Richard James
    14 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DR London
    Secrétaire
    14 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DR London
    British83245460001
    PALLOT, Hugh Glen
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    Secrétaire
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    British14485660002
    WILLIAMS, Adrian Charles Harold
    The Upper Flat
    94 Offord Road
    N1 1PF London
    Secrétaire
    The Upper Flat
    94 Offord Road
    N1 1PF London
    British103327620002
    ANGST, Kurt
    Lussirainstrasse 55
    FOREIGN 6300 Zug
    Switzerland
    Administrateur
    Lussirainstrasse 55
    FOREIGN 6300 Zug
    Switzerland
    Swiss13680770001
    AU, Wai-Fong
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    Administrateur
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    EnglandBritish124364220001
    BECKERSON, Ian David
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish73004250005
    BOGHE, Luc
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    BelgiumBelgian172508490001
    BOWER, Martin Andrew
    33 Burns Avenue
    SS13 3AG Basildon
    Essex
    Administrateur
    33 Burns Avenue
    SS13 3AG Basildon
    Essex
    British23307030001
    BURNS, Steven Paul
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish18761850004
    CALLAHAN, John Donald
    No 2
    The Landmark
    FOREIGN Northfield
    Illinois 60093
    Usa
    Administrateur
    No 2
    The Landmark
    FOREIGN Northfield
    Illinois 60093
    Usa
    Usa By Birth13680780001
    CLAYDEN, Dominic John
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    EnglandBritish183858000002
    COTTERILL, Brian Raymond
    Apartment 1305 Orchard Parksuites
    11 Orchard Turn
    FOREIGN Singapore 23880 Singapore
    Administrateur
    Apartment 1305 Orchard Parksuites
    11 Orchard Turn
    FOREIGN Singapore 23880 Singapore
    Australian57508210004
    CURTIS, Cheryl Karen
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish166056480001
    DODRIDGE, Philip Andrew
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish117364550002
    DONOVAN, Peter William
    6 Oldfield Close
    BR1 2LL Bromley
    Kent
    Administrateur
    6 Oldfield Close
    BR1 2LL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish56232250001
    DRABSCH, Neil Gregory
    26 Wyong Road Mosman
    Sydney 2088
    FOREIGN Nsw Australia
    Administrateur
    26 Wyong Road Mosman
    Sydney 2088
    FOREIGN Nsw Australia
    Australian57323210001
    FABER, Robert Thomas
    307 Churchill Court
    Sleepy Hollow
    Illinois 60118
    United States
    Administrateur
    307 Churchill Court
    Sleepy Hollow
    Illinois 60118
    United States
    Us Citizen39520250001
    FOGARTY, Desmond
    1 St Andrews
    Curragha
    Ashbourne
    Co Meath
    Ireland
    Administrateur
    1 St Andrews
    Curragha
    Ashbourne
    Co Meath
    Ireland
    Irish79250160001
    GLEN, Paul Edward
    Marlands Court
    Itchingfield
    RH13 0NN Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Marlands Court
    Itchingfield
    RH13 0NN Horsham
    West Sussex
    British43947920002
    GORDON, Joe
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    EnglandBritish182302840001
    GRANT, Robert Michael
    Betsoms Hill
    The Avenue
    TN16 2EE Westerham
    Kent
    Administrateur
    Betsoms Hill
    The Avenue
    TN16 2EE Westerham
    Kent
    British70624210001
    GROVE, Peter Ernest
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish4807730002
    GROVE, Peter Ernest
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Administrateur
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    United KingdomBritish4807730002
    HEDIEN, Wayne Evans
    2531 Shannon Road
    FOREIGN Northbrook
    Illinois 60062
    Usa
    Administrateur
    2531 Shannon Road
    FOREIGN Northbrook
    Illinois 60062
    Usa
    Usa By Birth13680740001
    HORGAN, Paul Liam
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    Administrateur
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish172495500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QBE RE (EUROPE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement6719948
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    QBE RE (EUROPE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 13 oct. 1998
    Livré le 16 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Any and all oligations of the company to the chargee under the security agreement or under any agreement
    Brèves mentions
    The "charged portfolio" meaning all the company's right title and interest in all securities held to the order for the account or under the control or direction of the bank in account number 6-411604-001 all securities held by any clearance system on behalf of or for the bank in the account numbered euroclear 20419 and cedel 35254 and all rights benefits and proceeds and sums of money for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 16 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Reinsurance deposit agreement
    Créé le 27 juin 1988
    Livré le 29 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 27.6.88.
    Brèves mentions
    All monies at the date of the reinsurance deposit agreement see 395 (M93) for details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 29 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 27 juin 1988
    Livré le 29 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the security agreement dated 27/6/88
    Brèves mentions
    Seeform 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 29 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of hypothecation
    Créé le 20 déc. 1985
    Livré le 08 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All bullion coinbills of exchange & other negotiable instruments & all bills of lading warrants & other documents of title to goods, debentures bonds stocks etc (see M45).
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 08 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    • 09 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0