VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED

VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01382864
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VILLAGE SQUASH LIMITED08 août 197808 août 1978

    Quels sont les derniers comptes de VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 20

    5 pagesMR05

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Hill House 1 Little New Street London London EC4A 3TR

    2 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sunita Kaushal en tant que secrétaire le 29 juil. 2014

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * 33 Cavendish Square London London W1G 0PW England* le 29 mai 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mai 2014

    État du capital au 29 mai 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    9 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* le 28 août 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David Caldecott en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* le 01 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Colin Elliot en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Caldecott le 05 nov. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Caldecott le 05 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* le 05 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* le 25 mai 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Maxwell Coppel le 05 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Caldecott le 05 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish163106000001
    ELLIOT, Colin David
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Administrateur
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish178756480001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Secrétaire
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    British123440090026
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    British15541980001
    KAUSHAL, Sunita
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Secrétaire
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    158962570001
    MARTLAND, David James
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    Secrétaire
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    British35477380001
    TURNOCK, Stephen Barry
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    British107764580001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secrétaire
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Administrateur
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BIRD, Paul Francis
    Foxhills 4 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Foxhills 4 Gorsey Lane
    WA14 4BN Altrincham
    Cheshire
    British89181330001
    CALDECOTT, David Gareth
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Administrateur
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    EnglandBritish73603940004
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    DERMODY, Paul Bernard
    6 Roe Green
    Worsley
    M28 2RF Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    6 Roe Green
    Worsley
    M28 2RF Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2207400002
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Administrateur
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish123440090026
    ENGLEFIELD, Edward Ashton
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    British35176020001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Brook House
    Brook Road
    CW6 9HH Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Brook House
    Brook Road
    CW6 9HH Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish109155280002
    HARRISON, Jonathan Charles
    Brambletye
    New Mill Road
    RG40 4QT Finchampstead
    Berkshire
    Administrateur
    Brambletye
    New Mill Road
    RG40 4QT Finchampstead
    Berkshire
    British51526360001
    LAKE, Trevor Rex
    Glen Royd
    15 Saint Albans Road
    HX3 0ND Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Glen Royd
    15 Saint Albans Road
    HX3 0ND Halifax
    West Yorkshire
    British38334390003
    MCNALLY, Anthony Francis
    7 Bell Meadow Court
    CW6 0DT Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    7 Bell Meadow Court
    CW6 0DT Tarporley
    Cheshire
    British63045710001
    REED, Stuart James
    9 Elm Rise
    Prestbury
    SK10 4US Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    9 Elm Rise
    Prestbury
    SK10 4US Macclesfield
    Cheshire
    British2250490001
    REID, Hubert Valentine
    The Old Rectory
    Cocksmoss Lane Marton
    SK11 9HX Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Cocksmoss Lane Marton
    SK11 9HX Macclesfield
    Cheshire
    British34122950001
    SINGH, Jagtar
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish121710890001
    SINGLETON, Paul James
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    British79357110001
    STOREY, Martin John
    Ysgubor Newydd
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    Administrateur
    Ysgubor Newydd
    Nannerch
    CH7 5RD Mold
    Clwyd
    British35968160001
    STUBBS, Roger Gordon
    Beech House
    36 Parkgate Road, Neston
    CF64 6QG South Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Beech House
    36 Parkgate Road, Neston
    CF64 6QG South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish4795660002
    TURNOCK, Stephen Barry
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    8 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish107764580001
    ZANRE, Renaldo
    Lyndale Beechcroft
    BR7 5DB Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Lyndale Beechcroft
    BR7 5DB Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish11893590001

    VILLAGE LEISURE HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 mars 2010
    Livré le 17 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the security agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 17 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 sept. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 06 mars 1987
    Livré le 07 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500,000 and any other monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brèves mentions
    Fixed charge over:- premises at george st. Prestwich manchester and premises in dukinfield rd, hyde, cheshire. Fixed & moveable plant equipment, furniture, fixtures, fittings. Goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Boddingtons' Breweries Limited.
    Transactions
    • 07 mars 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 16 juil. 1986
    Livré le 18 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Brèves mentions
    1) fixed charge over premises in dukinfield road, hyde, cheshire 2) fixed & moveable plant equipment furniture, fixtures, fittings. 3) goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Boddingtons' Breweries Public Limited Company
    Transactions
    • 18 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1986
    Livré le 16 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and any other moneys that may become owing by the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Brèves mentions
    Village squash club hyde cheshire tog with the goodwill of the business and the book & other debts please see doc M29.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Webster and Wilsons Limited
    Transactions
    • 16 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 févr. 1986
    Livré le 25 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £125,000 and any other moneys that may become owing by the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brèves mentions
    Fixed charge over (a) f/h premises at george st prestwich manchester (b) premises at dukinfield rd hyde cheshire all the fixed moveable plant equipment furniture fixtures & fittings affixed or situate about the properties, the goodwill of the business carried on at or from the properties.
    Personnes ayant droit
    • Boddingtons' Breweries Public Limited Company.
    Transactions
    • 25 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1990Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 sept. 1985
    Livré le 12 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £200,000 and any monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brèves mentions
    Village squash club george street, prestwich and village squash club dukinfield road, hyde. Title no gm 356483 gm 193646 and gm 232244 together with the goodwill of the business and book debts.
    Personnes ayant droit
    • Wilsons Brewery Limited
    Transactions
    • 12 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    • 29 mars 1990Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 1985
    Livré le 12 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £330,546
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south west side of george street prestwich bury greater manchester land lying to the west of dukinfield road hyde and land k/a newton wood house dukinfield rd hyde tameside greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Thornham Construction Company LTD
    Transactions
    • 12 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1990Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 1985
    Livré le 09 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc M24. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Credit Services Limited
    Transactions
    • 09 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1990Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1984
    Livré le 04 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H newton wood house dukinfield road hythe greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 01 mai 1990Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1984
    Livré le 31 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £94666.72 and any other moneys that may become owing by the company tothe chargee on account current of stated for goods supplied or otherwise.
    Brèves mentions
    F/H land & premises situate in george street, prestwich bury, greater manchester title no:- gm 232244 all fixed and moveable plant equipment fixtures and fittings goodwill of the business.
    Personnes ayant droit
    • Boddingtons' Brewers Public Limited Company
    Transactions
    • 31 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1982
    Livré le 08 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the village, george stret off bury new road sedgley park prestwich manchester greater manchester title no gm 232244.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1982
    Livré le 08 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land lying to the west of dukinfield road now a squash complex captain clark road off dukinfield road hyde greater manchester title no gm 193646.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 09 sept. 1982
    Livré le 16 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. And all fixtures plant and machinery (please see doc M16).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 05 août 1982
    Livré le 07 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land on the west side of george street prestwich bury. Title no gm 232244.
    Personnes ayant droit
    • Boddingtons Breweries Public Limited Company
    Transactions
    • 07 août 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 08 janv. 1982
    Livré le 15 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & bldgs. Registered under title no:- gm 232244 tog. With the goodwill of the business carried on thereat.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Credit Services Limited
    Transactions
    • 15 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    Irrevocable authority
    Créé le 05 févr. 1981
    Livré le 17 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Squash complex captain clarke road off dukinfield road hyde, cheshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    Irrevocable authority
    Créé le 05 févr. 1981
    Livré le 10 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1.75 acres of land on the south side of george street, prestwich greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 09 déc. 1980
    Livré le 12 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands & premises being 1.75 acres situate on the south side of george street prestwich, bury greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 24 oct. 1980
    Livré le 30 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands & premises known as squash complex, captain clarke road, off dukinfield road, hyde cheshire. Title no:- gm 193646. tog. With all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 28 mai 1980
    Livré le 11 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over (see doc M9). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0