PHOENIX FOODS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PHOENIX FOODS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01397554 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PHOENIX FOODS LIMITED ?
Adresse du siège social | 4b Christchurch House Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester Kent England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PHOENIX FOODS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PHOENIX FOODS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation | |
---|---|
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 19 juin 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX FOODS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Retrait de la demande de radiation de la société | 1 pages | DS02 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de John Nagle en tant que directeur le 14 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de John Nagle en tant que secrétaire le 14 déc. 2018 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes modifiés pour une petite société jusqu'au 31 mars 2016 | 16 pages | AAMD | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016 | 3 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de PHOENIX FOODS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRBY, Michael James | Administrateur | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House Kent England | United Kingdom | British | Director | 49079440007 | ||||
BROWN, Joan Elizabeth | Secrétaire | 14 Fircroft Close Hillview Road GU22 7LZ Woking Surrey | British | 14888930003 | ||||||
CUNNINGHAM BROWN, Robert | Secrétaire | Crest House Middle Wallop SO20 8EG Stockbridge | British | 84281080001 | ||||||
KIPLING, Jeffrey Robert | Secrétaire | 79 Westgate Guiseley LS20 8HH Leeds West Yorkshire | British | Accountant | 16759880001 | |||||
MESSIAS, Jeffrey Jacob | Secrétaire | 118 Bryanston Court Ii 137 George Street W1H 7HE London | British | 73761350009 | ||||||
NAGLE, John | Secrétaire | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House Kent England | 204360590001 | |||||||
OBRIEN, Peter Francis | Secrétaire | 6 Irthing Ellington NE61 5LP Morpeth Northumberland | British | Director | 75914190001 | |||||
STEWART, Gareth John | Secrétaire | Prince Road Poynton SK12 1TW Stockport 2 Cheshire | British | Director | 131994900001 | |||||
TERRY, Christopher Malcolm | Secrétaire | Monkswell Park Manse Lane HG5 8NQ Knaresborough Unit 7 North Yorkshire United Kingdom | 184209330001 | |||||||
BROWN, Robert Cunningham | Administrateur | Crest House Middle Wallop SO20 8EG Stockbridge Hampshire | British | Company Director | 100394640001 | |||||
CUNNINGHAM-BROWN, Kenneth Owen | Administrateur | Danebury Place Middle Wallop SO20 6JX Stockbridge Hants | United Kingdom | British | Company Director | 14888940001 | ||||
DUCKER, Andrew James | Administrateur | Lillington Road CV32 6LF Leamington Spa 63a Warwickshire England | United Kingdom | British | Accountant | 140698250001 | ||||
DYER, Neil Maurice | Administrateur | Monkswell Park Manse Lane HG5 8NQ Knaresborough Unit 7 North Yorkshire United Kingdom | England | United Kingdom | Chemical Engineer | 71140500001 | ||||
KERSHAW, Edward John, Lord | Administrateur | 38 High View Hempsted GL2 5LN Gloucester Gloucestershire | England | British | Chartered Accountant | 15235010001 | ||||
KIPLING, Jeffrey Robert | Administrateur | 79 Westgate Guiseley LS20 8HH Leeds West Yorkshire | England | British | Accountant | 16759880001 | ||||
LOMAX, Richard Anthony | Administrateur | 38 Redcar Drive Eastham CH62 8HE Wirral Cheshire | England | British | Director | 103767380001 | ||||
MANNING, David Brown | Administrateur | Home Farm Hanley Swan WR8 0EF Worcester | United Kingdom | British | Director | 118638810002 | ||||
MESSIAS, Jeffrey Jacob | Administrateur | 118 Bryanston Court Ii 137 George Street W1H 7HE London | British | Accountant | 73761350009 | |||||
NAGLE, John | Administrateur | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House Kent England | United Kingdom | British | Accountant | 110378680001 | ||||
OBRIEN, Peter Francis | Administrateur | 6 Irthing Ellington NE61 5LP Morpeth Northumberland | British | Director | 75914190001 | |||||
RUTTER, Gary | Administrateur | 16 St Thomas Way Green Hammerton YO26 8BE York | England | British | Engineer | 94752980001 | ||||
STEWART, Gareth John | Administrateur | Prince Road Poynton SK12 1TW Stockport 2 Cheshire | British | Director | 131994900001 | |||||
TERRY, Christopher Malcolm, Mr. | Administrateur | Phoenix Foods Ltd Brakey Road, Weldon Industrial Estate NN17 5LU Corby Phoenix Foods Ltd Northamptonshire Nn17 5lu United Kingdom | England | British | Accountant | 60746700002 | ||||
WILDING, Colin Neil | Administrateur | Monkswell Park Manse Lane HG5 8NQ Knaresborough Unit 7 North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 131994880001 | ||||
WOOLLEY, James Christopher Michael | Administrateur | Charnley Drive LS7 4ST Leeds 49 West Yorkshire | Britain | British | Accountant | 131958320001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHOENIX FOODS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciaty Powders Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0