WOOD GROUP KENNY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWOOD GROUP KENNY LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01398385
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    • Activités de conseil scientifique et technique liées à l'ingénierie (71122) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    J P KENNY LIMITED27 janv. 199927 janv. 1999
    J. P. KENNY LIMITED04 janv. 199604 janv. 1996
    J.P. KENNY & PARTNERS LIMITED07 nov. 197807 nov. 1978

    Quels sont les derniers comptes de WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 sept. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation17 sept. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 sept. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024

    29 pagesAA

    legacy

    270 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 03 sept. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Wood Group Kenny Corporate Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2023

    2 pagesPSC05

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023

    28 pagesAA

    legacy

    261 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Nomination de Ms Sarah Marion Macrury en tant que secrétaire le 04 juil. 2024

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Iain Angus Jones en tant que secrétaire le 12 juin 2024

    1 pagesTM02

    Nomination de Miss Gemma Louise Garner en tant qu'administrateur le 15 mars 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kerry Milne en tant que directeur le 15 mars 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022

    25 pagesAA

    legacy

    261 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kerry Milne le 09 sept. 2022

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MACRURY, Sarah Marion
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Secrétaire
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    324927110001
    BEERE, Alan Frank
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    EnglandBritish299233240001
    GARNER, Gemma Louise
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    ScotlandBritish320997920001
    BROWN, Charles Nicholas
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    Stoneyards Farm
    Menie By Balmedie
    AB41 0YJ Aberdeen
    Grampian
    British36752260001
    BROWN, Robert Muirhead Birnie
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Secrétaire
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    153840380001
    GOOD, Graham
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    Secrétaire
    22 Gladstone Place
    AB10 6XA Aberdeen
    British57781370001
    JOHNSON, Ian
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Secrétaire
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    British102664100004
    JONES, Iain Angus
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Secrétaire
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    203968940001
    WATSON, Christopher Edward Milne
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    Secrétaire
    77 Fountainhall Road
    AB15 4EA Aberdeen
    British60315030001
    WSM SERVICES LIMITED
    Derwent House
    35 South Park Road
    SW19 8RR London
    Secrétaire
    Derwent House
    35 South Park Road
    SW19 8RR London
    30807900001
    ANGUS, Grant Rae
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    ScotlandBritish197743170001
    BAKER, David William
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Administrateur
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    EnglandBritish37632970001
    BOAN, Richard
    Cedar Cottage Blighton Lane
    Seale
    GU10 1PU Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Cedar Cottage Blighton Lane
    Seale
    GU10 1PU Farnham
    Surrey
    British51274310001
    BROWN, Robert Muirhead Birnie
    Thames Plaza 5 Pine Trees
    Chertsey Lane
    TW18 3DT Staines
    Middlesex
    Administrateur
    Thames Plaza 5 Pine Trees
    Chertsey Lane
    TW18 3DT Staines
    Middlesex
    Uk/ScotlandBritish153830110001
    CASSON, Ivor
    7 Hill View
    Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    Administrateur
    7 Hill View
    Primrose Hill Road
    NW3 3AX London
    British5538180001
    DAVIES, Paul, Doctor
    34 Regents Park Road
    NW1 7TR London
    Administrateur
    34 Regents Park Road
    NW1 7TR London
    EnglandUnited Kingdom5684290001
    EDGAR, William
    3 Cairnie View
    Westhill
    AB32 6NB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    3 Cairnie View
    Westhill
    AB32 6NB Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish109447840001
    FOTHERINGHAM, Alan Rae
    Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point 79-87
    Middlesex
    Administrateur
    Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point 79-87
    Middlesex
    ScotlandBritish1159760002
    FRAMPTON, Keith Anthony
    6 Hope Fountain
    Camberley
    Surrey
    Administrateur
    6 Hope Fountain
    Camberley
    Surrey
    British20875080003
    HEMINGWAY, Andrew Peter
    Shinfield Park
    Shinfield
    RG2 9FW Reading
    Shinfield House
    England
    Administrateur
    Shinfield Park
    Shinfield
    RG2 9FW Reading
    Shinfield House
    England
    EnglandBritish256499160001
    KENNY, John Patrick
    15 Austen Road
    GU1 3NW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    15 Austen Road
    GU1 3NW Guildford
    Surrey
    EnglandUnited Kingdom44984250001
    MACDONALD, Robert Alexander
    Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point 79-87
    Middlesex
    Administrateur
    Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point 79-87
    Middlesex
    ScotlandBritish138754550001
    MACFARLANE, David Archibald
    4 Rosebery Street
    AB2 4LL Aberdeen
    Administrateur
    4 Rosebery Street
    AB2 4LL Aberdeen
    British37509080001
    MCINTOSH, Roderick Fraser
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Administrateur
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    EnglandBritish56910170004
    MCKINNON, Colin Breton
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Administrateur
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    EnglandBritish58078730001
    MIDDLETON, Bruce
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Administrateur
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    ScotlandBritish170566840001
    MILNE, Kerry
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    Administrateur
    Justice Mill Lane
    AB11 6EQ Aberdeen
    15
    Scotland
    ScotlandBritish298412290002
    NOBLE, Trevor Mills
    Ferndell 17 Milner Drive
    KT11 2EZ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Ferndell 17 Milner Drive
    KT11 2EZ Cobham
    Surrey
    EnglandBritish25131120001
    O'SULLIVAN, Timothy Gerard
    Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point 79-87
    Middlesex
    Administrateur
    Kingston Road
    TW18 1DT Staines
    Compass Point 79-87
    Middlesex
    ScotlandIrish101244610002
    PERCIVAL, David Robin
    11 Lamborne Close
    GU47 8JL Sandhurst
    Berkshire
    Administrateur
    11 Lamborne Close
    GU47 8JL Sandhurst
    Berkshire
    EnglandBritish64840320001
    RAVEN, Philip William John, Dr
    3 Rawdon Rise
    Springfield Road
    GU15 1AV Camberley
    Surrey
    Administrateur
    3 Rawdon Rise
    Springfield Road
    GU15 1AV Camberley
    Surrey
    British43006280001
    RAVEN, Philip William John, Dr
    3 Rawdon Rise
    Springfield Road
    GU15 1AV Camberley
    Surrey
    Administrateur
    3 Rawdon Rise
    Springfield Road
    GU15 1AV Camberley
    Surrey
    British43006280001
    STRAUGHEN, Michael
    68 Rubislaw Den North
    AB15 4AN Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    68 Rubislaw Den North
    AB15 4AN Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish68935280002
    WAYMAN, Stephen John
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Surrey
    Scotland
    Administrateur
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Surrey
    Scotland
    EnglandBritish57913330007
    WILLIAMS, Gerwyn James Maxwell
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    Administrateur
    Greenwell Road
    East Tullos Industrial Estate
    AB12 3AX Aberdeen
    John Wood House
    Scotland
    United KingdomBritish217519960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOOD GROUP KENNY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wood Group Kenny Corporate Limited
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    06 avr. 2016
    Hareness Road
    Altens Industrial Estate
    AB12 3LE Aberdeen
    Sir Ian Wood House
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies In Scotland
    Numéro d'enregistrementSc147353
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0