PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED

PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01401160
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?

    • construction de navires et de structures flottantes (30110) / Industries manufacturières

    Où se situe PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    32 Threadneedle Street
    EC2R 8AY London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SLINGSBY ENGINEERING LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    BUSTINO INVESTMENTS LIMITED22 nov. 197822 nov. 1978

    Quels sont les derniers comptes de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Burness Paull Llp en tant que secrétaire le 19 août 2013

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Paull & Williamsons Llp en tant que secrétaire le 19 août 2013

    1 pagesTM02

    Nomination de James Lawrence Mcculloch en tant que secrétaire le 19 août 2013

    2 pagesAP03

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Hazel Hunter en tant que secrétaire le 26 avr. 2013

    1 pagesTM02

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de One London Wall London EC2Y 5AB le 11 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 sept. 2012

    État du capital au 04 sept. 2012

    • Capital: GBP 2,695,347
    SH01

    legacy

    5 pagesMG01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Whelan Harris le 11 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Hazel Hunter en tant que secrétaire le 01 déc. 2011

    2 pagesAP03

    Nomination de Paull & Williamsons Llp en tant que secrétaire le 11 nov. 2011

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Euan Alexander Edmondston Leask en tant que secrétaire le 30 sept. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Jarrod Stephen Marsden en tant que secrétaire le 11 nov. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Maclay Murray & Spens Llp en tant que secrétaire le 11 nov. 2011

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Euan Alexander Edmondston Leask le 19 juin 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Euan Alexander Edmondston Leask le 19 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Maclay Murray & Spens Llp le 29 mars 2011

    2 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    25 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCULLOCH, James Lawrence
    920 Memorial City Way
    Suite 1000
    TX 770224 Houston
    Forum Energy Technologies Inc.
    Texas
    Usa
    Secrétaire
    920 Memorial City Way
    Suite 1000
    TX 770224 Houston
    Forum Energy Technologies Inc.
    Texas
    Usa
    180949830001
    BURNESS PAULL LLP
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Secrétaire
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleSCOTLAND, SCOTS LAW
    Numéro d'enregistrementSO300380
    99448920005
    HARRIS, James Whelan
    (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza
    Scotland
    Administrateur
    (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Union Plaza
    Scotland
    United StatesAmerican159701740001
    TAYLOR, Kevin
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    Administrateur
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    British74777230002
    BERRY, David William
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    British1415970002
    COOPER, Simon Astley
    The Grey Horse Great Edstone
    YO62 6PD York
    Secrétaire
    The Grey Horse Great Edstone
    YO62 6PD York
    British6172510002
    COOPER, Simon Astley
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    British6172510001
    CORRAY, Pamela Jane
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    British83551930001
    FRENCH, Wayne Ian
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    Secrétaire
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    British104188800001
    HUNTER, Hazel
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 0PS Aberdeen
    Forum Energy Technologies (Uk) Limited
    Scotland
    Secrétaire
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 0PS Aberdeen
    Forum Energy Technologies (Uk) Limited
    Scotland
    165470940001
    LEASK, Euan Alexander Edmondston
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    Secrétaire
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    British129769730001
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    British2641580001
    MARSDEN, Jarrod Stephen
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ings Lane
    YO62 6EZ Kirkbymoorside
    Perry Slingsby Systems Limited
    York
    United Kingdom
    British68707320003
    MONTEL, Aline
    44 Rue Didot
    75014 Paris
    France
    Secrétaire
    44 Rue Didot
    75014 Paris
    France
    French44495200001
    PIRIE, William Allan
    Skene
    AB32 6RP Westhill
    Sunnybrae House
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Skene
    AB32 6RP Westhill
    Sunnybrae House
    Aberdeenshire
    British139601340001
    WALTERS, Logan
    5534 Schumacher
    Houston
    Texas 77056
    Usa
    Secrétaire
    5534 Schumacher
    Houston
    Texas 77056
    Usa
    British124901190001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Secrétaire désigné
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    900003400001
    PAULL & WILLIAMSONS LLP
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    6th Floor Union Plaza
    Scotland
    Secrétaire
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    6th Floor Union Plaza
    Scotland
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleCOMPANIES ACT 2006
    Numéro d'enregistrementSO302228
    137701650001
    ADDIS, Robert Campbell
    57 Schoolhill
    AB41 9AJ Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    57 Schoolhill
    AB41 9AJ Ellon
    Aberdeenshire
    British60172730003
    ANDERSON, Martin Taylor
    Sambaiba
    Kinstair Farm
    AB33 8HL Alford
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Sambaiba
    Kinstair Farm
    AB33 8HL Alford
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish151543830001
    BERRY, David William
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Derwent House 137 Scarborough Road
    Norton
    YO17 8AD Malton
    North Yorkshire
    British1415970002
    BOE, Knut
    Nesaasen 18b
    Nesbru
    1394
    Norway
    Administrateur
    Nesaasen 18b
    Nesbru
    1394
    Norway
    NorwayNorwegian84068980001
    BRYSON, John Macdonald
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    British10076550001
    CASSIE, David
    32 Westholme Avenue
    AB15 6AB Aberdeen
    Administrateur
    32 Westholme Avenue
    AB15 6AB Aberdeen
    ScotlandBritish50942380001
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    British73934900001
    COOPER, Simon Astley
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    Administrateur
    30 Knapton Close
    Strensall
    YO3 5ZF York
    North Yorkshire
    British6172510001
    CORRAY, Pamela Jane
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    British83551930001
    COYARD, Ivan Roland
    Tour Technip-Coflexip
    La Defense 6 170 Place Henri
    Regnault Paris La Defense
    92973
    France
    Administrateur
    Tour Technip-Coflexip
    La Defense 6 170 Place Henri
    Regnault Paris La Defense
    92973
    France
    French84562970001
    DELMOTTE, Alain-Hugues
    2 Avenue Lenotre
    78160 Marly Le Roi
    Paris
    France
    Administrateur
    2 Avenue Lenotre
    78160 Marly Le Roi
    Paris
    France
    FranceFrench116419150001
    FABY, Michael Joseph
    139 Fairview West
    33469 Tequesta
    Florida
    Usa
    Administrateur
    139 Fairview West
    33469 Tequesta
    Florida
    Usa
    American59698200002
    FRENCH, Wayne Ian
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    3 Oakfields
    Allbrook
    SO50 4RP Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritish104188800001
    LANNON-DECLERCQ, Christine
    44 Rue Du Commerce
    FOREIGN Paris
    75015
    France
    Administrateur
    44 Rue Du Commerce
    FOREIGN Paris
    75015
    France
    French70700980001
    LEASK, Euan Alexander Edmondston
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    Woodburn Road
    Blackburn
    AB21 OPS Aberdeen
    Tgh (Uk) Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish129769730001
    LEATT, Allen Frederick
    1 Allee Zenaga
    Vaucresson
    92420
    France
    Administrateur
    1 Allee Zenaga
    Vaucresson
    92420
    France
    British58322980005
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish2641580001

    PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 août 2012
    Livré le 31 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 02 févr. 2007
    Livré le 09 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and for and on Behalf of Thefinance Parties
    Transactions
    • 09 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture
    Créé le 07 août 1992
    Livré le 17 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 1985
    Livré le 06 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at ingslane, kirbymoorside, north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 janv. 1985
    Livré le 06 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 12 mars 1984
    Livré le 20 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts present and future.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 20 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 04 oct. 1988Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0