PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01401160 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 32 Threadneedle Street EC2R 8AY London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomination de Burness Paull Llp en tant que secrétaire le 19 août 2013 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paull & Williamsons Llp en tant que secrétaire le 19 août 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de James Lawrence Mcculloch en tant que secrétaire le 19 août 2013 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hazel Hunter en tant que secrétaire le 26 avr. 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de One London Wall London EC2Y 5AB le 11 sept. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 5 pages | MG01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Whelan Harris le 11 nov. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Hazel Hunter en tant que secrétaire le 01 déc. 2011 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Paull & Williamsons Llp en tant que secrétaire le 11 nov. 2011 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Euan Alexander Edmondston Leask en tant que secrétaire le 30 sept. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jarrod Stephen Marsden en tant que secrétaire le 11 nov. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Maclay Murray & Spens Llp en tant que secrétaire le 11 nov. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Euan Alexander Edmondston Leask le 19 juin 2011 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Euan Alexander Edmondston Leask le 19 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Maclay Murray & Spens Llp le 29 mars 2011 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 25 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCULLOCH, James Lawrence | Secrétaire | 920 Memorial City Way Suite 1000 TX 770224 Houston Forum Energy Technologies Inc. Texas Usa | 180949830001 | |||||||||||||||
| BURNESS PAULL LLP | Secrétaire | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 United Kingdom |
| 99448920005 | ||||||||||||||
| HARRIS, James Whelan | Administrateur | (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza Scotland | United States | American | 159701740001 | |||||||||||||
| TAYLOR, Kevin | Administrateur | Ings Lane YO62 6EZ Kirkbymoorside Perry Slingsby Systems Limited York United Kingdom | British | 74777230002 | ||||||||||||||
| BERRY, David William | Secrétaire | Derwent House 137 Scarborough Road Norton YO17 8AD Malton North Yorkshire | British | 1415970002 | ||||||||||||||
| COOPER, Simon Astley | Secrétaire | The Grey Horse Great Edstone YO62 6PD York | British | 6172510002 | ||||||||||||||
| COOPER, Simon Astley | Secrétaire | 30 Knapton Close Strensall YO3 5ZF York North Yorkshire | British | 6172510001 | ||||||||||||||
| CORRAY, Pamela Jane | Secrétaire | 146 Hamilton Place AB15 5BB Aberdeen Aberdeenshire | British | 83551930001 | ||||||||||||||
| FRENCH, Wayne Ian | Secrétaire | 3 Oakfields Allbrook SO50 4RP Eastleigh Hampshire | British | 104188800001 | ||||||||||||||
| HUNTER, Hazel | Secrétaire | Woodburn Road Blackburn AB21 0PS Aberdeen Forum Energy Technologies (Uk) Limited Scotland | 165470940001 | |||||||||||||||
| LEASK, Euan Alexander Edmondston | Secrétaire | Woodburn Road Blackburn AB21 OPS Aberdeen Tgh (Uk) Limited United Kingdom | British | 129769730001 | ||||||||||||||
| LOVERIDGE, James Douglas | Secrétaire | 10 Redding Drive HP6 5PX Amersham Buckinghamshire | British | 2641580001 | ||||||||||||||
| MARSDEN, Jarrod Stephen | Secrétaire | Ings Lane YO62 6EZ Kirkbymoorside Perry Slingsby Systems Limited York United Kingdom | British | 68707320003 | ||||||||||||||
| MONTEL, Aline | Secrétaire | 44 Rue Didot 75014 Paris France | French | 44495200001 | ||||||||||||||
| PIRIE, William Allan | Secrétaire | Skene AB32 6RP Westhill Sunnybrae House Aberdeenshire | British | 139601340001 | ||||||||||||||
| WALTERS, Logan | Secrétaire | 5534 Schumacher Houston Texas 77056 Usa | British | 124901190001 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire désigné | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | 900003400001 | |||||||||||||||
| PAULL & WILLIAMSONS LLP | Secrétaire | 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen 6th Floor Union Plaza Scotland |
| 137701650001 | ||||||||||||||
| ADDIS, Robert Campbell | Administrateur | 57 Schoolhill AB41 9AJ Ellon Aberdeenshire | British | 60172730003 | ||||||||||||||
| ANDERSON, Martin Taylor | Administrateur | Sambaiba Kinstair Farm AB33 8HL Alford Aberdeenshire | United Kingdom | British | 151543830001 | |||||||||||||
| BERRY, David William | Administrateur | Derwent House 137 Scarborough Road Norton YO17 8AD Malton North Yorkshire | British | 1415970002 | ||||||||||||||
| BOE, Knut | Administrateur | Nesaasen 18b Nesbru 1394 Norway | Norway | Norwegian | 84068980001 | |||||||||||||
| BRYSON, John Macdonald | Administrateur | Edgton Little Tangley Wonersh GU5 0PW Guildford Surrey | British | 10076550001 | ||||||||||||||
| CASSIE, David | Administrateur | 32 Westholme Avenue AB15 6AB Aberdeen | Scotland | British | 50942380001 | |||||||||||||
| CLARK, Robin Hartley Ledgerd | Administrateur | Glebe Cottage Rockbourne SP6 3NA Fordingbridge Hampshire | British | 73934900001 | ||||||||||||||
| COOPER, Simon Astley | Administrateur | 30 Knapton Close Strensall YO3 5ZF York North Yorkshire | British | 6172510001 | ||||||||||||||
| CORRAY, Pamela Jane | Administrateur | 146 Hamilton Place AB15 5BB Aberdeen Aberdeenshire | British | 83551930001 | ||||||||||||||
| COYARD, Ivan Roland | Administrateur | Tour Technip-Coflexip La Defense 6 170 Place Henri Regnault Paris La Defense 92973 France | French | 84562970001 | ||||||||||||||
| DELMOTTE, Alain-Hugues | Administrateur | 2 Avenue Lenotre 78160 Marly Le Roi Paris France | France | French | 116419150001 | |||||||||||||
| FABY, Michael Joseph | Administrateur | 139 Fairview West 33469 Tequesta Florida Usa | American | 59698200002 | ||||||||||||||
| FRENCH, Wayne Ian | Administrateur | 3 Oakfields Allbrook SO50 4RP Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | 104188800001 | |||||||||||||
| LANNON-DECLERCQ, Christine | Administrateur | 44 Rue Du Commerce FOREIGN Paris 75015 France | French | 70700980001 | ||||||||||||||
| LEASK, Euan Alexander Edmondston | Administrateur | Woodburn Road Blackburn AB21 OPS Aberdeen Tgh (Uk) Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 129769730001 | |||||||||||||
| LEATT, Allen Frederick | Administrateur | 1 Allee Zenaga Vaucresson 92420 France | British | 58322980005 | ||||||||||||||
| LOVERIDGE, James Douglas | Administrateur | 10 Redding Drive HP6 5PX Amersham Buckinghamshire | England | British | 2641580001 |
PERRY SLINGSBY SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 29 août 2012 Livré le 31 août 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 02 févr. 2007 Livré le 09 févr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 07 août 1992 Livré le 17 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 25 janv. 1985 Livré le 06 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land at ingslane, kirbymoorside, north yorkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 janv. 1985 Livré le 06 févr. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 12 mars 1984 Livré le 20 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts and other debts present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0