MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED

MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01403501
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Level 12 The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TWO FLAGS EXCELLENCE LIMITED15 juin 199915 juin 1999
    TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED05 sept. 199605 sept. 1996
    AMR TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED19 avr. 199419 avr. 1994
    TWO FLAGS LIMITED04 déc. 197804 déc. 1978

    Quels sont les derniers comptes de MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    17 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    16 pagesLIQ10

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Stephanie Alison Pound le 23 mai 2023

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 mars 2023

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy Mark Williams le 19 juil. 2021

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 déc. 2020 au 31 mars 2021

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Jeremy Mark Williams en tant qu'administrateur le 07 avr. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Maclellan International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 déc. 2020

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT à Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street London SE1 9SG le 02 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard John Butler en tant que directeur le 30 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Katherine Woods en tant qu'administrateur le 30 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mitie Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 30 nov. 2020

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Stephanie Alison Pound en tant que secrétaire le 30 nov. 2020

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Stephanie Alison Pound le 15 mars 2020

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Secrétaire
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5228356
    148474450001
    POUND, Stephanie Alison
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish213930870003
    WILLIAMS, Jeremy Mark
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    EnglandBritish280831530001
    WOODS, Katherine
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    Administrateur
    The Shard,
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12
    England
    United KingdomBritish237400250001
    BLACKBURN, Peter Edward
    1 The Old Orchard
    CV35 9RW Wellesbourne
    Warwickshire
    Secrétaire
    1 The Old Orchard
    CV35 9RW Wellesbourne
    Warwickshire
    British75964810001
    COOPER, Philip William
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    British9839440001
    FERNLEY, Renee Amy Margaret
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    British6221020001
    GREEN, Kevin Hartley
    15 Manor Farm Close
    Barton Le Clay
    MK45 4TB Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    15 Manor Farm Close
    Barton Le Clay
    MK45 4TB Bedford
    Bedfordshire
    British72862750001
    MARLETT, Charles David
    5756 Stonegate Road
    75209 Dallas
    Texas
    Usa
    Secrétaire
    5756 Stonegate Road
    75209 Dallas
    Texas
    Usa
    American34256160002
    POUND, Stephanie Alison
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Secrétaire
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    British77355850005
    PRICE, Mairead Brigid
    17 Beech Road
    Hollywood
    B47 5QS Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    17 Beech Road
    Hollywood
    B47 5QS Birmingham
    West Midlands
    British117736250001
    SHIPLEY, Stephen Robert
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    69 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DL Solihull
    West Midlands
    British16575040001
    ASHDOWN, Simon Trayton
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Administrateur
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish117331880001
    BAKER, Robert Woodward
    17 Lundys Lane
    75080 Dallas
    Texas
    Usa
    Administrateur
    17 Lundys Lane
    75080 Dallas
    Texas
    Usa
    Usa34900830001
    BROOKS, David Robert
    3412 Centenary Avenue
    Dallas
    Tx75225
    Usa
    Administrateur
    3412 Centenary Avenue
    Dallas
    Tx75225
    Usa
    American48194490001
    BUTLER, Richard John
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Administrateur
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish213849970003
    CARTY, Donald John
    3907 Gillon Avenue
    Dallas
    Texas 75205
    Usa
    Administrateur
    3907 Gillon Avenue
    Dallas
    Texas 75205
    Usa
    Canadian,American34256150001
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Administrateur
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    British49800090001
    COOPER, Philip William
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    34 Alban Road
    SG6 2AT Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish9839440001
    CRANDALL, Robert Lloyd
    5423 Park Lane
    Dallas
    Texas 75220
    Usa
    Administrateur
    5423 Park Lane
    Dallas
    Texas 75220
    Usa
    American46751890001
    ELLIS, John Leslie
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    21 Oakfields Avenue
    SG3 6NP Knebworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish25380370003
    FERNLEY, Michael John
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    Administrateur
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    British6221030001
    FERNLEY, Renee Amy Margaret
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    Administrateur
    7 Northcroft Road
    Englefield Green
    TW20 0DP Egham
    Surrey
    British6221020001
    GRAVENEY, Mark
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Administrateur
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    British126722400001
    GUNN, George James
    360 E Randolph £3801
    Chicago
    Il 60601
    Usa
    Administrateur
    360 E Randolph £3801
    Chicago
    Il 60601
    Usa
    American48194530001
    MELIZAN, Bruce Anthony
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Administrateur
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    United KingdomBritish,Trinidadian92905500001
    METZLER, Thomas Michael
    3918 Fox Glen Drive
    Irving Texas 75062
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    3918 Fox Glen Drive
    Irving Texas 75062
    FOREIGN Usa
    American39634340002
    PLEDGE, Nicholas Christopher
    31 Bolton Crescent
    SL4 3JH Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    31 Bolton Crescent
    SL4 3JH Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish120621490001
    POULTER, Michael John
    Redwood Lodge Pump Lane North
    SL7 3RD Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Redwood Lodge Pump Lane North
    SL7 3RD Marlow
    Buckinghamshire
    British23113980001
    REHILL, Daljit Singh
    102 Berkeley Avenue
    TW4 6LB Hounslow
    Middlesex
    Administrateur
    102 Berkeley Avenue
    TW4 6LB Hounslow
    Middlesex
    British46370490001
    SIBLEY, Anthony William
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    United KingdomBritish13317120001
    SIBLEY, Roseleen
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    Boa Vista Higham Road
    Higham Gobian
    SG5 3HR Hitchin
    Hertfordshire
    Irish7179710001
    SPENCER, Bernard William
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Administrateur
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish98205010002
    WATSON, Michael Stuart
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Administrateur
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    EnglandBritish188269720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Maclellan International Limited
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    06 avr. 2016
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Level 12. The Shard
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUk Company Law
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement03688689
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 oct. 2004
    Livré le 27 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 oct. 2000
    Livré le 06 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 avr. 1999
    Livré le 26 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 11 nov. 1996
    Livré le 27 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or excellence PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 oct. 1996
    Livré le 28 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts the subject of an invoice discounting agreement and all rights in favour of the company related to such debts and all other amounts and by way of a floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the above amounts as shall for the time being stand released form the fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 28 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mars 2023Commencement of winding up
    15 mars 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Caroline Rifkind
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0