JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED

JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 01405252
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOCHRENCH LIMITED13 déc. 197813 déc. 1978

    Quels sont les derniers comptes de JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Forms b & z convert to rs
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 15/06/2016
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 1,020,002
    3 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 sept. 2015

    État du capital au 03 sept. 2015

    • Capital: GBP 1,020,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2014

    État du capital au 02 sept. 2014

    • Capital: GBP 1,020,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Patrick Moynihan en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Paul Lang en tant qu'administrateur le 30 juin 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2013

    État du capital au 17 sept. 2013

    • Capital: GBP 1,020,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Philip James Crossland le 01 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Moynihan le 01 sept. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cws (No 1) Limited le 01 sept. 2013

    2 pagesCH02

    Cessation de la nomination de Caroline Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stephen Humes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2013

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* le 04 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Mr Stephen Humes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martyn Hulme en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martyn Wates en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150082080001
    CROSSLAND, Anthony Philip James
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritish125492370001
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish170146830001
    CWS (NO 1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1925625
    36139970001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    HUTTON, Leonard Frederick
    76 Bramble Lane
    NG18 3NX Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    76 Bramble Lane
    NG18 3NX Mansfield
    Nottinghamshire
    British35215050001
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150082320001
    STEPHENSON, William Henry
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    British1720730001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    CWS (NO 2) LIMITED
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    36139760001
    ARNOLD, Neil
    41 Broadway
    NE30 2LL Tynemouth
    Tyne & Wear
    Administrateur
    41 Broadway
    NE30 2LL Tynemouth
    Tyne & Wear
    British9900230001
    COX, Michael William
    22 Wilson Gardens
    Gosforth
    NE3 4JA Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    22 Wilson Gardens
    Gosforth
    NE3 4JA Newcastle Upon Tyne
    British58082720001
    DOHERTY, Frank Edgar
    Thrumpton House
    NG11 0AX Thrumpton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Thrumpton House
    NG11 0AX Thrumpton
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish1720740001
    GILL, Giles
    25 Lime Grove
    NG13 0BH Bottesford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    25 Lime Grove
    NG13 0BH Bottesford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish98662510001
    HEWITT, Paul William
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish163759450001
    HULME, Martyn Alan
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish77326830003
    HULME, Martyn Alan
    15 Knightsbridge Drive
    NG16 1RD Nuthall
    Nottinghamshire
    Administrateur
    15 Knightsbridge Drive
    NG16 1RD Nuthall
    Nottinghamshire
    British77326830002
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish84087790001
    JACKSON, David James
    82 Horseshoe Lane
    Bromley Cross
    BL7 9RR Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    82 Horseshoe Lane
    Bromley Cross
    BL7 9RR Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish102840001
    MARRIOTT, David Samuel
    16 Fern Close
    NG25 0DB Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    16 Fern Close
    NG25 0DB Southwell
    Nottinghamshire
    British22991720001
    MAXWELL, Alan
    Westpoint Cottage
    42 School Lane
    LE7 3RT South Croxton
    Leicester
    Administrateur
    Westpoint Cottage
    42 School Lane
    LE7 3RT South Croxton
    Leicester
    British26297780008
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish87719730001
    STEPHENSON, William Henry
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    14 The Links
    NG18 3HW Mansfield
    Nottinghamshire
    British1720730001
    TAYLOR, Melvyn James
    22 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    22 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    West Midlands
    British325690001
    WATES, Martyn James
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish60114700002

    JAMES WINDSOR AND SON (MANSFIELD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 15 oct. 1990
    Livré le 16 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 1990
    Livré le 18 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a composite guarantee and mortgage debenture dated 31-5-90
    Brèves mentions
    F/H land & building on east side of nottingham road mansfield t/no nt 114610.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 1990
    Livré le 18 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a composite guarantee and mortgage debenture dated 31-5-90
    Brèves mentions
    F/H land & buildings on north west of baums lane mansfield t/no nt 128882.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 juin 1990
    Livré le 26 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a composite guarantee and mortgage debenture dated 31.5.90
    Brèves mentions
    F/H k/a hammonds (now windsors) garage 175 to 193 (odd no) mansfield road daybrook l/b nottinghamshire gedling t/no nt 61238.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 26 juin 1990Enregistrement d'une charge
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 31 mai 1990
    Livré le 07 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Bank Public Limited Companyas Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 07 juin 1990Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1986
    Livré le 07 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold 175-193, mansfield road, daybrook and property on oxclose lane, arnold, nottinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0