SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED

SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01414175
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sca Packaging Finance Shared
    Service Centre Faverdale
    DL3 0PE Faverdale Industrial Estate
    Darlington Co Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KIRBY CARTONS LIMITED22 mars 198922 mars 1989
    COLIN KIRBY (HOLDINGS) LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    YOOGALI LIMITED09 févr. 197909 févr. 1979

    Quels sont les derniers comptes de SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 mai 2009

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    6 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Secrétaire
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    HEYS, Thomas David
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    Administrateur
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    EnglandBritish133589280001
    HOVINGTON, Stphen Paul
    Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    9
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    9
    North Yorkshire
    British138340970001
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    British60781190001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Secrétaire
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    British45838190001
    TOWERS, Joanne Sara
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British12355220002
    BROWN, John Keith
    Harvel Cottage 30 Hallatrow Road
    Paulton
    BS39 7LJ Bristol
    Administrateur
    Harvel Cottage 30 Hallatrow Road
    Paulton
    BS39 7LJ Bristol
    EnglandBritish60781220001
    GIBBONS, Anthony
    8 Wells Green
    Barton
    DL10 6NH Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    8 Wells Green
    Barton
    DL10 6NH Richmond
    North Yorkshire
    British60781120002
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Administrateur
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    EnglandBritish60781190001
    KIRBY, Colin Walter
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British5390460002
    KIRBY, Hilary June
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Apartment 28 Little Aston Hall
    Little Aston
    B74 3BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British6412080002
    KIRBY, Kerry Ann
    6 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    6 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish45081270001
    KIRBY, Nicholas Andrew
    200 Walsall Road
    B74 4QB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    200 Walsall Road
    B74 4QB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British61556150001
    KIRBY, Simon Colin
    35 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    35 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British62605760002
    MANSELL, Philip Peter
    7 Stag Drive
    Woodhaven
    WS12 4UJ Huntington
    Staffordshire
    Administrateur
    7 Stag Drive
    Woodhaven
    WS12 4UJ Huntington
    Staffordshire
    United KingdomBritish264683610001
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    British28463460001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Irish108501020001
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish72400470001
    TOWERS, Joanne Sara
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish12355220002
    TOWERS, Richard John
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    37 Somerville Road
    B73 6HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish58877370002
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    British74014480001

    SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 09 avr. 1997
    Livré le 22 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 avr. 1997
    Livré le 22 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land & buildings on the south side of lynn lane shenstone staffordshire t/n SF267170 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 avr. 1997
    Livré le 22 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land lying to the south of lynn lane shenstone staffordshire t/n SF161660 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 oct. 1995
    Livré le 07 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a geest premises lynn lane shenstone staffs t/no.SF267170 and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 févr. 1995
    Livré le 25 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £135,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Kirby Directors Pension Scheme
    Transactions
    • 25 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 1991
    Livré le 05 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property of the company at lynn lane shenotone lichfield t/no:- sf 161660. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 avr. 1989
    Livré le 21 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property at lynn lane shenstone lichfield t/no sf 161660 model 4050 automatic litho sheet lamintor with straight through machines configuration and automatic base material feed.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 28 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal second mortgage
    Créé le 24 déc. 1986
    Livré le 08 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H industrial premises & land at lynn lane shenstone, nr lichfield, staffs.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 24 déc. 1986
    Livré le 08 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 oct. 1983
    Livré le 04 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 1982
    Livré le 10 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold factory premises and land at the south of lynn lane, shenstone, lichfield, staffordshire title number sf 161660.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Guarantee and debenture
    Créé le 03 avr. 1981
    Livré le 23 avr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or kirby containers limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital. Buildings fixtures, fixed plant and machinery (see doc m 15).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1981Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 21 mai 1980
    Livré le 24 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future goodwill including uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1980Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 09 avr. 1980
    Livré le 14 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate near lynn lane, shenstone, staffordshire with all buildings and fixtures thereon.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 juin 1979
    Livré le 15 juin 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital stock in trade work in progress, prepayments & investments together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 15 juin 1979Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SCA PACKAGING KIRBY CARTONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 avr. 2010Dissolved on
    28 mai 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0