HEY (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEY (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01414745
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEY (UK) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HEY (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    33 Cavendish Square
    W1G 0PW London
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEY (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEY SOFT DRINKS (U.K.) COMPANY LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981

    Quels sont les derniers comptes de HEY (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HEY (UK) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HEY (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR

    2 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 déc. 2014

    État du capital au 18 déc. 2014

    • Capital: GBP 39,554
    SH01

    Cessation de la nomination de Sunita Kaushal en tant que secrétaire le 29 juil. 2014

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2013

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 déc. 2013

    État du capital au 17 déc. 2013

    • Capital: GBP 39,554
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 33 Cavendish Square London London W1B 0PW England* le 27 août 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David Caldecott en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* le 01 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Colin Elliot en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Gareth Caldecott le 18 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Caldecott le 05 nov. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Caldecott le 05 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * 17 Portland Place London London W1B 1PU England* le 05 sept. 2012

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Maxwell Coppel le 05 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sunita Kaushal le 05 déc. 2011

    2 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * 1 West Garden Place Kendal Street London W2 2AQ England* le 05 déc. 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de HEY (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish163106000001
    ELLIOT, Colin David
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Administrateur
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    United KingdomBritish178756480001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Secrétaire
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    British123440090026
    KAUSHAL, Sunita
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Secrétaire
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    158956040001
    RAMSBOTTOM, Peter
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    British881150001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secrétaire
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Administrateur
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BREARLEY, John Richard
    206 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8TX Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    206 Bramhall Lane
    Davenport
    SK3 8TX Stockport
    Cheshire
    British1575980001
    CALDECOTT, David Gareth
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    Administrateur
    Portland Place
    W1B 1PU London
    17
    London
    England
    EnglandBritish73603940004
    CAVE, Ian Bruce
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    392 Woodstock Road
    OX2 8AF Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish102741680001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    EDWARDS, David Charles
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    Administrateur
    Greenbanks Close
    Milford On Sea
    SO41 0SQ Lymington
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish123440090026
    ENGLEFIELD, Edward Ashton
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    British35176020001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    LISTER, Steven Bernard Lewis
    Keepers Cottage
    Ashwith By Pilsley
    S45 8AN Chesterfield
    Administrateur
    Keepers Cottage
    Ashwith By Pilsley
    S45 8AN Chesterfield
    British10137610001
    LONGDEN, John David
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Vicarage House
    Nidd
    HG3 3BN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish40890250001
    MARTLAND, David James
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    Administrateur
    73 Hall Lane
    Aspull
    WN2 2SF Wigan
    Greater Manchester
    British35477380001
    MCEVOY, John James
    17 Grangeway
    Handforth
    SK9 3HY Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    17 Grangeway
    Handforth
    SK9 3HY Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish48091070001
    PARKINSON, Joseph Edward
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    Administrateur
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    United KingdomBritish4553470004
    RAMSBOTTOM, Peter
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Flat 5 Netherleigh Court
    S40 3PR Chesterfield
    Derbyshire
    British881150001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    Administrateur
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SINGLETON, Paul James
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    15 Kingsway Avenue
    Broughton
    PR3 5JN Preston
    Lancashire
    British79357110001
    SPIEGELBERG, Anthony William Assheton
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish24626450001
    WHITE, Christopher Geoffrey
    Woodbine Brown Heath Road
    Christleton
    CH3 7PN Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Woodbine Brown Heath Road
    Christleton
    CH3 7PN Chester
    Cheshire
    British58547200001

    HEY (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third supplemental trust deed
    Créé le 16 sept. 1998
    Livré le 01 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee the principal of and interest on the stock, being £99,650,450 11 1/2 per cent. Debenture stock 2014 of the greenalls group PLC and any further debenture stock of the greenalls group PLC created or issued pursuant to clause 3 of the principal trust deed, and all other monies intended to be secured by the principal trust deed dated 5 june 1991, any deed expressed to be supplemental thereto and any other deed or instrument conferring rights on the chargee executed or entered into pursuant to the principal trust deed or any deed supplemental thereto
    Brèves mentions
    The undertaking and all the property and assets present and future wherever situated (including any uncalled capital) of the company by way of first floating charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 01 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second supplemental trust deed
    Créé le 16 sept. 1998
    Livré le 24 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The guarantee by the company to the trustee of the payment by the greenalls group PLC of all sums on account of the principal of or interest on the £30,000,000 10 1/2 per cent.(formerly 10 1/4 per cent) debenture stock 2017 (repayable on 23RD june 2017 or such earlier date as the security constituted by the trust deed the supplemental trust deed and the second supplemental trust deed becomes enforceable and the trustee determines or becomes bound to enforce the same) and of any moneys intended to be secured by the second supplemental trust deed
    Brèves mentions
    First floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 août 1991
    Livré le 08 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land k/as depot mangham road barbot hall industrial estate rotherham south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 févr. 1990
    Livré le 28 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold lands being depot,mangham road,barbot hall industrial,rotherham,south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1989
    Livré le 07 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Estate right title or interest (if any) or in a plot of land situate on the east side of skinner lane pontefract west yorkshire including beneficial interest in the property or in the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1989
    Livré le 07 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings situate off bondgate,knottingley road and atkinson lane. Pontefract t/n wyk 339842 and plot of land situate off bondgate,knottingley road including interest in property or in the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 juin 1989
    Livré le 12 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in barrys lane scarborough north yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 mai 1989
    Livré le 19 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Two freehold plots of land one situate between westfield road and holm flatt street in parkgate rotherham with the depot and offices erected thereon or on some part thereof and theother situate some short distance to the north east and also being in westgage with the buildings erected thereon or on some part thereof and used as a garage and store.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1989
    Livré le 17 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and building at spawd bone lane,knottingley,west yorkshire.t/no.wyk 21390 and part of t/no.wyk 427817.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1989
    Livré le 17 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at carnaby road bridlington T.no. Hs 1667.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1989
    Livré le 17 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings off station road,ushaw moor,county durham.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1989
    Livré le 17 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings situate at skinner lane pontefract west yorkshire T.no wyk 20616.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 27 avr. 1989
    Livré le 11 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1988
    Livré le 08 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings spawd bone lanes knottingley,west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 06 juin 1988
    Livré le 10 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a on being land and buildings on the south side of lancaster road carnaby bridlington humberside t/n H.S. 1667 registered at H.M. land registry.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1987
    Livré le 01 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 févr. 1987
    Livré le 20 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h land and buildings on the east side of skinner lane, pontefract, west yorkshire title no wyk 20616.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 févr. 1987
    Livré le 20 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The right title or interest of hey soft drinks (UK) company limited of and in a plot of land situate on the east side ofskenner lane, pontefract, west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0