TECHNICAL TOOLING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTECHNICAL TOOLING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01415847
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARDMERE LIMITED20 févr. 197920 févr. 1979

    Quels sont les derniers comptes de TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration de confirmation établie le 30 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Corporation Service Company (Uk) Limited le 15 avr. 2021

    1 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Justin Neil Clarke en tant qu'administrateur le 03 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Horace Vincent Draa Iii en tant que directeur le 02 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2018

    3 pagesAAMD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 24 juil. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Horace Vincent Draa Iii en tant que secrétaire le 15 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Nomination de Corporation Service Company (Uk) Limited en tant que secrétaire le 15 avr. 2019

    2 pagesAP04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Nomination de Mr. Neil Lawrence Jowsey en tant qu'administrateur le 07 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ronald Ernst Baarslag en tant que directeur le 07 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CORPORATION SERVICE COMPANY (UK) LIMITED
    Churchill Place
    E14 5HU London
    5 Churchill Place, 10th Floor
    England
    Secrétaire
    Churchill Place
    E14 5HU London
    5 Churchill Place, 10th Floor
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03226320
    216788570001
    CLARKE, Justin Neil, Mr.
    Chartwell Drive
    LE18 2FS Wigston
    65
    England
    Administrateur
    Chartwell Drive
    LE18 2FS Wigston
    65
    England
    United KingdomBritishGeneral Counsel184467260002
    JOWSEY, Neil Lawrence, Mr.
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Administrateur
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    EnglandBritishBusiness Executive250475600001
    DRAA III, Horace Vincent, Mr.
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Secrétaire
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    236553990001
    LADBROOKE, Timothy
    8 Cleveland Avenue
    Long Eaton
    NG10 2BT Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    8 Cleveland Avenue
    Long Eaton
    NG10 2BT Nottingham
    Nottinghamshire
    British27305480002
    STANUKINAS, Paul Joseph, Mr.
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Secrétaire
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    221924320001
    BAARSLAG, Ronald Ernst
    Zevenheuvelenwig 44
    5048 An Tilburg
    Fabory
    Netherlands
    Administrateur
    Zevenheuvelenwig 44
    5048 An Tilburg
    Fabory
    Netherlands
    NetherlandsDutchBusiness Executive239092020001
    DRAA III, Horace Vincent, Mr.
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Administrateur
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    United StatesAmericanBusiness Executive236558680001
    GREGORY, Michael
    Rutland Manor
    Belton-In-Rutland
    LE15 9LD Leicestershire
    Administrateur
    Rutland Manor
    Belton-In-Rutland
    LE15 9LD Leicestershire
    EnglandBritishDirector152024330001
    KERINS, Michael
    1 Millstream Grange
    DE72 3TP Borrowash
    Derbyshire
    Administrateur
    1 Millstream Grange
    DE72 3TP Borrowash
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector68388990005
    LADBROOKE, Timothy
    8 Cleveland Avenue
    Long Eaton
    NG10 2BT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    8 Cleveland Avenue
    Long Eaton
    NG10 2BT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector27305480002
    LEE, Alan
    197 Derby Road
    Borowash
    DE72 3FE Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    197 Derby Road
    Borowash
    DE72 3FE Derby
    Derbyshire
    BritishDirector32937830001
    MORTIBOYS, Gary
    41 Willoughby Drive
    Hillfields
    B91 3GB Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    41 Willoughby Drive
    Hillfields
    B91 3GB Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector48074880001
    RAWLINSON II, David Lee
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Administrateur
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    EnglandAmericanDirector200641150002
    SEALEY, David
    2 Dorchester Drive
    NG18 4QQ Mansfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    2 Dorchester Drive
    NG18 4QQ Mansfield
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector61276890002
    STANUKINAS, Paul Joseph
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    Administrateur
    P O Box 14
    65 Chartwell Drive
    LE18 1AT Wigston
    Leicester
    NetherlandsAmericanDirector205947540002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TECHNICAL TOOLING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cromwell Tools (Rochester) Limited
    Chartwell Drive
    14
    LE18 1AT Wigston
    65
    Leicestershire
    England
    19 mai 2016
    Chartwell Drive
    14
    LE18 1AT Wigston
    65
    Leicestershire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleThe Companies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement2557653
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    TECHNICAL TOOLING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22 november 2000 and
    Créé le 07 août 2009
    Livré le 11 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22 november 2000 and
    Créé le 30 janv. 2009
    Livré le 10 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22 november 2000 and
    Créé le 29 janv. 2009
    Livré le 10 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 05 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1991
    Livré le 30 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book and other debts and other monetary claims due to the company.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 29 sept. 1988
    Livré le 03 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge dated 29/9/88
    Brèves mentions
    112 mansfield road chester green derby.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Anglia Building Society
    Transactions
    • 03 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 1982
    Livré le 26 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on goodwill book and other debts together with fixtures and fittings (incl trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery (please see doc M18). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transactions
    • 26 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 21 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0