GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED

GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01416732
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5JR
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EVERANGE LIMITED23 févr. 197923 févr. 1979

    Quels sont les derniers comptes de GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 janv. 2018

    • Capital: GBP 4
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share prem acc reduced 17/01/2018
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Rib Directors 1 Limited en tant que directeur le 29 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rib Directors 2 Limited en tant que directeur le 29 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rib Secretaries Limited en tant que secrétaire le 27 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Re Secretaries Limited en tant que secrétaire le 27 oct. 2016

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2016

    État du capital au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 475,491.12
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan William Mcculloch le 14 mars 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juin 2015

    État du capital au 30 juin 2015

    • Capital: GBP 475,491.12
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    1 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    That the directors of the company be given powers pursuant to section 175 of the act 03/11/2014
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Section 175 03/11/2014
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juil. 2014

    État du capital au 10 juil. 2014

    • Capital: GBP 475,491.12
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RE SECRETARIES LIMITED
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Secrétaire
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement292732
    1327670012
    MCCULLOCH, Alan William
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish170986900001
    UDOW, Henry Adam
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritish125126820001
    CROSER, William James
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    Secrétaire
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    British58808760002
    RIB SECRETARIES LIMITED
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Secrétaire
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    32438680003
    BOVILL, Michael Antony
    Long Acre
    Chalk Lane, East Horsley
    KT24 6TJ Leatherhead
    Administrateur
    Long Acre
    Chalk Lane, East Horsley
    KT24 6TJ Leatherhead
    United KingdomBritish112204460001
    CHARKIN, Richard Denis Paul
    52 Southmoor Road
    OX2 6RD Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    52 Southmoor Road
    OX2 6RD Oxford
    Oxfordshire
    British22140670001
    COWDEN, Stephen John
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Administrateur
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    British510780002
    CROSER, William James
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Smallwood Lodge
    Longparish
    SP11 7AJ Andover
    Hampshire
    British58808760002
    DIXON, Leslie
    Tonbridge Road
    Mereworth
    ME18 5JE Maidstone
    Belmont House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Tonbridge Road
    Mereworth
    ME18 5JE Maidstone
    Belmont House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish830710002
    RADCLIFFE, Willoughby Mark St John
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    Administrateur
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    EnglandBritish32447610001
    RIB DIRECTORS 1 LIMITED
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Administrateur
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    32501660011
    RIB DIRECTORS 2 LIMITED
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    Administrateur
    1-3 Strand
    WC2N 5JR London
    32499130008

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Strand
    WC2N 5JR London
    1-3
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2746621
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GEORGE PHILIP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 20 juil. 1983
    Livré le 06 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the existing security documents.
    Brèves mentions
    Fixed charge on the book debts & other debts due or owing to the company both present & future.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC.
    Transactions
    • 06 août 1983Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 avr. 1979
    Livré le 18 avr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies advanced or to become advanced under the terms of an agreement dated 10/4/79 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • I.C.F.C. LTD.
    Transactions
    • 18 avr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0