O I E SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéO I E SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01418001
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de O I E SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Autres activités des agences de placement (78109) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe O I E SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    361-366 Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de O I E SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPTIMA INTEGRATED ENERGY SERVICES LIMITED07 déc. 200107 déc. 2001
    INTEGRATED ENERGY SERVICES LIMITED24 oct. 200124 oct. 2001
    DIETSMANN MORGAN MOORE LIMITED31 déc. 199831 déc. 1998
    DIETSMANN (U.K.) LIMITED01 sept. 198201 sept. 1982
    MAC FELLOW LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    METVENUS LIMITED08 mai 197908 mai 1979

    Quels sont les derniers comptes de O I E SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour O I E SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 23 avr. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England à 361-366 Buckingham Avenue Slough SL1 4LU le 19 janv. 2018

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Murray Jamieson Crane le 15 déc. 2017

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Adam Powell en tant que secrétaire le 15 déc. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Murray Jamieson Crane en tant que secrétaire le 15 déc. 2017

    2 pagesAP03

    Nomination de John Ritchie Morrison en tant qu'administrateur le 15 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Florin Ianul en tant que directeur le 15 juin 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2016

    17 pagesAA

    Nomination de Florin Ianul en tant qu'administrateur le 31 mars 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Adam David Powell en tant qu'administrateur le 31 mars 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard John Paddison en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    23 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de O I E SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARNE, Murray Jamieson
    Centurion Court
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    Scotland
    Secrétaire
    Centurion Court
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    Scotland
    241237780002
    DONATIELLO, John
    c/o John Crane Group Corporation
    W. Monroe Street
    Chicago
    227
    Il 60606
    United States
    Administrateur
    c/o John Crane Group Corporation
    W. Monroe Street
    Chicago
    227
    Il 60606
    United States
    United StatesAmerican202354100001
    MORRISON, John Ritchie
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    United Kingdom
    Administrateur
    North Esplanade West
    AB11 5QH Aberdeen
    Centurion Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish236416530001
    POWELL, Adam David
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    361-366
    England
    Administrateur
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    361-366
    England
    United KingdomBritish229623250001
    DAWSON, Anthony Robert
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    Secrétaire
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    British16917220001
    KROMBEEN, Leendert
    2 Fernbank
    CM12 9XH Billericay
    Essex
    Secrétaire
    2 Fernbank
    CM12 9XH Billericay
    Essex
    British7875650001
    POWELL, Adam
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Secrétaire
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    202356300001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    PETERKINS SERVICES LIMITED
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Secrétaire
    Union Street
    AB10 1QR Aberdeen
    100
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC184957
    154002830001
    BUCHANAN, George
    Mill Of Mondynes
    Fordoun
    AB30 1LB Laurencekirk
    Kincardineshire
    Administrateur
    Mill Of Mondynes
    Fordoun
    AB30 1LB Laurencekirk
    Kincardineshire
    ScotlandBritish44846630001
    CAVANAGH, Mark James
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    Administrateur
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    United KingdomBritish43031460003
    CAVANAGH, Victoria
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    Administrateur
    Rubislaw Den South
    AB15 4BB Aberdeen
    32
    Scotland
    ScotlandBritish159055800001
    DAWSON, Anthony Robert
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    Administrateur
    Huntington
    Upper Ickneild Way Whiteleaf
    HP27 0LL Princes Risborough Aylesbury
    Bucks
    EnglandBritish16917220001
    DELPECH, Pierre
    18 Chemin D'Orange
    13100 Aix En Provence
    Marsielle
    France
    Administrateur
    18 Chemin D'Orange
    13100 Aix En Provence
    Marsielle
    France
    French75213150001
    IANUL, Florin
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Administrateur
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    RomaniaRomanian229632930001
    KUTEMANN, Peter Renhart Gunnar
    3 Avenue Princess Grace
    FOREIGN Monaco 98000
    Administrateur
    3 Avenue Princess Grace
    FOREIGN Monaco 98000
    Dutch40690770002
    MAIN, Michael Robert
    2 Kirkton Road
    Westhill
    AB32 6LF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    2 Kirkton Road
    Westhill
    AB32 6LF Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish109530520001
    PADDISON, Richard John
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Administrateur
    c/o Bond Dickinson Llp
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    EnglandBritish63501590001
    RICHMOND, Robert Campbell Connor
    29 Burns Road
    AB15 4NT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    29 Burns Road
    AB15 4NT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British1009910001
    THAIN, Walter
    26 S Riverside View
    Riverside Drive
    AB11 7DF Aberdeen
    Administrateur
    26 S Riverside View
    Riverside Drive
    AB11 7DF Aberdeen
    British78371700001
    VAN DEN BERGE, Johan Herman Bernhard
    Oude Galgenstraat 132
    Kapellen
    2950
    Belgium
    Administrateur
    Oude Galgenstraat 132
    Kapellen
    2950
    Belgium
    Dutch75269810001
    VELTMAN, Willem Jan Petrus
    Casa Capricornio
    Valle Hermoso
    Al Havrin El Grande
    Apartado 36
    Espana
    Administrateur
    Casa Capricornio
    Valle Hermoso
    Al Havrin El Grande
    Apartado 36
    Espana
    Dutch25005180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur O I E SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    John Crane Group Ltd
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    Buckingham House
    England
    06 avr. 2016
    Buckingham Avenue
    SL1 4LU Slough
    Buckingham House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Cardiff
    Numéro d'enregistrement05137825
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    O I E SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 07 mai 2015
    Livré le 11 mai 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchase debts and floating charge on bank proceeds of debts
    Créé le 08 oct. 2001
    Livré le 12 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the invoice discounting agreement or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge (1) all receivables purchased or purported to be purchased by the security holder from the company pursuant to a discounting agreement between the security holder and the company which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason (2) all other debts of the company and (3) the benefit of all guarantees indemnities, instruments and securities given to or held by the company in relation to any such receivable or other debt and the right to other records and documents on or by which any such receivable or other debt is recorded or evidenced 3 (1) fixed equitable charge all purchased debts and the other debts etc (2) floating charge such of the monies received etc.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 04 oct. 2001
    Livré le 18 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from searosa limited to the chargee and dietsmann holding (cyprus) limited under the terms of a loan and security agreement of even date
    Brèves mentions
    The whole property (including uncalled capital) property and undertaking of the company.
    Personnes ayant droit
    • Dietsmann N.V.
    Transactions
    • 18 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of offset.
    Créé le 24 avr. 1992
    Livré le 11 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from linbide (G.B.)limited /and or dietsmann management services limited on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of the bank of scotland in the name of dietsmann (U.K.) limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland .
    Transactions
    • 11 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of contract monies
    Créé le 05 oct. 1990
    Livré le 16 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights arising from contract no. C/45985/89/AO2 for ship manning of the msv stadive between shell UK limited (shell UK exploration and production) & dietsmann (UK) limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charge
    Créé le 12 sept. 1990
    Livré le 21 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of. Offset
    Créé le 06 août 1990
    Livré le 27 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from dietsmann management systems limitedunder the terms of the charge.
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of dietsmann (UK) LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of assignment
    Créé le 28 sept. 1983
    Livré le 18 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies due to dietsmann (UK) limited under the contract no c/42196/83/OA7 between dietsmann (UK) limited and shell (U.K.) limited.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez.
    Transactions
    • 18 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    • 12 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    O I E SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 sept. 2010Date of completion or termination of CVA
    27 mai 2008Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Mark Draine
    Moore Stephens
    3/5 Rickmansworth Road
    WD18 0GX Watford
    Hertfordshire
    practitioner
    Moore Stephens
    3/5 Rickmansworth Road
    WD18 0GX Watford
    Hertfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0