CLOUDSURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLOUDSURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01420136
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLOUDSURE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CLOUDSURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lindred House 20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLOUDSURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SERVO COMPUTER SERVICES LIMITED18 oct. 200618 oct. 2006
    SERVO COMPUTER SERVICES PLC31 déc. 198031 déc. 1980
    DOWERBOND LIMITED16 mai 197916 mai 1979

    Quels sont les derniers comptes de CLOUDSURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour CLOUDSURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    7 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Lewis Mcglennon le 30 nov. 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Philip Thompson en tant qu'administrateur le 12 nov. 2021

    2 pagesAP01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed servo computer services LIMITED\certificate issued on 04/11/21
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 nov. 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    9 pagesAA

    Notification de Daisy Telecoms Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 juil. 2019

    2 pagesPSC02

    Cessation de Daisy It Managed Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 juil. 2019

    1 pagesPSC07

    Modification des détails de Daisy It Managed Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 avr. 2019

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Daisy House, Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR England à Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR le 29 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Nathan Richard Marke en tant que directeur le 01 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Lewis Mcglennon en tant que secrétaire le 01 févr. 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CLOUDSURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCGLENNON, David Lewis
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Administrateur
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish181536600002
    SMITH, Stephen Alan
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Administrateur
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    United KingdomBritish161471940001
    THOMPSON, Neil Philip
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    Administrateur
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    EnglandBritish158049040002
    BADGER, Nicholas
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    British18158340002
    MARTIN, William Thomas
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Weavers Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    British57302660001
    MCGLENNON, David Lewis
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Secrétaire
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    199438630001
    STOKES, Reeta
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    173997430001
    TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    Secrétaire
    The Lakes
    Bedford Road
    NN4 7HD Northampton
    Lakeside House
    Northamptonshire
    England
    179707420001
    WRAGG, Keith
    80 Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4WU Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    80 Slayley View Road
    Barlborough
    S43 4WU Chesterfield
    Derbyshire
    British50768630002
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    Administrateur
    Lindred Road Business Park
    Nelson
    BB9 5SR Lancashire
    Daisy House
    England
    England
    United KingdomBritish294355310001
    BADGER, Nicholas
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    British18158340002
    BADGER, Nicholas
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    50 Wyvern Gardens
    Dore
    S17 3PR Sheffield
    South Yorkshire
    British18158340002
    BERTRAM, Peter Michael
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    EnglandBritish52852920002
    BILLING, Roger Stephen
    Belgrave House
    Belgrave Drive
    S10 3LQ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Belgrave House
    Belgrave Drive
    S10 3LQ Sheffield
    South Yorkshire
    British66939500001
    BODILL, Timothy John
    Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton-On-Trent
    16
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton-On-Trent
    16
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140942610001
    BURROWS, Nigel
    Greystone Head
    Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard
    HG4 3RU Ripon
    N Yorks
    Administrateur
    Greystone Head
    Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard
    HG4 3RU Ripon
    N Yorks
    British35683460001
    CLUTTON, Steven
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish158222570001
    COURTLEY, David John
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish141213480001
    FARROW, Matthew James
    34 Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    Administrateur
    34 Lychgate Close
    LE10 2ES Burbage
    Leicestershire
    EnglandBritish194105960001
    HOWARTH, Mark Edward John
    8 Parsons Grove
    Denby Village
    DE5 8PY Ripley
    Derbyshire
    Administrateur
    8 Parsons Grove
    Denby Village
    DE5 8PY Ripley
    Derbyshire
    British79403870001
    JACKSON, Peter Daniel
    The Orchard Main Street
    Heath
    S44 5SA Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    The Orchard Main Street
    Heath
    S44 5SA Chesterfield
    Derbyshire
    British23515580002
    JONES, David Emrys
    Biggin House
    Biggin By Hulland
    DE6 3FJ Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Biggin House
    Biggin By Hulland
    DE6 3FJ Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandEnglish211566200001
    LLOYD, Neil Anthony
    7 Kenwyn Road
    SW20 8TR London
    Administrateur
    7 Kenwyn Road
    SW20 8TR London
    EnglandBritish181988860001
    LOCKWOOD, Robert John Harry
    37 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    37 The Mount
    Wrenthorpe
    WF2 0NZ Wakefield
    West Yorkshire
    British111070890001
    MARKE, Nathan Richard
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish194292450001
    MARTIN, William Thomas
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Technology House
    Hunsbury Hill Avenue
    NN4 8QS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish57302660001
    MOAKES, Philip
    Hall Cliffe Cottage
    Back Lane, Warslow
    SK17 0JL Buxton
    Derbyshire
    Administrateur
    Hall Cliffe Cottage
    Back Lane, Warslow
    SK17 0JL Buxton
    Derbyshire
    EnglandBritish94198370001
    MULLER, Neil Keith
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    EnglandBritish252490400001
    PODMORE, Victor Gerald
    12 Middlefield Drive
    Great Finborough
    IP14 3AH Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    12 Middlefield Drive
    Great Finborough
    IP14 3AH Stowmarket
    Suffolk
    British15200080001
    RILEY, Matthew Robinson
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Lindred Road Business Park
    BB9 5SR Nelson
    Daisy House,
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish178585250001
    ROBINSON, Nicholas John
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    Ferry Nab Lane
    SL7 2EZ Medmanham
    Ferry Nab
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish54873290006
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British54873290005
    ROBINSON, Nicholas
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Wethered Road
    SL7 2BH Marlow
    Buckinghamshire
    British54873290005
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Administrateur
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritish80817560001
    SMITH, William Joe
    Belstead Old Rectory
    Copdock
    IP8 3JS Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Belstead Old Rectory
    Copdock
    IP8 3JS Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish20327120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLOUDSURE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    12 juil. 2019
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement6977942
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    06 avr. 2016
    20 Lindred Road
    Brierfield
    BB9 5SR Nelson
    Lindred House
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01983540
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CLOUDSURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 oct. 2001
    Livré le 07 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 05 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 05 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1994
    Livré le 06 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Servo house bakewell road darley dale matlock derbyshire t/nody 246529.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 mars 1992
    Livré le 13 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Servo house, littlemoor, eckington, sheffield, N.E.derbyshire. T/no.DY151593 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 août 1987
    Livré le 02 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £210,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    F/H the drill hall, littlemoor, echington, derbyshire. Title no dy 151593.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Fire Insurance Society Limited
    Transactions
    • 02 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 28 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 nov. 1982
    Livré le 09 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1982Enregistrement d'une charge
    • 28 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 07 janv. 1981
    Livré le 14 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold 6/10 sheffield road, dronfield, derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 janv. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0