CLOUDSURE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CLOUDSURE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01420136 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CLOUDSURE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CLOUDSURE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour CLOUDSURE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 7 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Lewis Mcglennon le 30 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Philip Thompson en tant qu'administrateur le 12 nov. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed servo computer services LIMITED\certificate issued on 04/11/21 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 9 pages | AA | ||||||||||
Notification de Daisy Telecoms Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 juil. 2019 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Daisy It Managed Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 juil. 2019 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Modification des détails de Daisy It Managed Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 avr. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Daisy House, Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR England à Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR le 29 avr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nathan Richard Marke en tant que directeur le 01 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Lewis Mcglennon en tant que secrétaire le 01 févr. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018 | 16 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CLOUDSURE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGLENNON, David Lewis | Administrateur | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 181536600002 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Administrateur | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | 161471940001 | |||||
| THOMPSON, Neil Philip | Administrateur | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | England | British | 158049040002 | |||||
| BADGER, Nicholas | Secrétaire | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| MARTIN, William Thomas | Secrétaire | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Secrétaire | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | 199438630001 | |||||||
| STOKES, Reeta | Secrétaire | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | 173997430001 | |||||||
| TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Secrétaire | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179707420001 | |||||||
| WRAGG, Keith | Secrétaire | 80 Slayley View Road Barlborough S43 4WU Chesterfield Derbyshire | British | 50768630002 | ||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Administrateur | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| BADGER, Nicholas | Administrateur | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| BADGER, Nicholas | Administrateur | 50 Wyvern Gardens Dore S17 3PR Sheffield South Yorkshire | British | 18158340002 | ||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Administrateur | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| BILLING, Roger Stephen | Administrateur | Belgrave House Belgrave Drive S10 3LQ Sheffield South Yorkshire | British | 66939500001 | ||||||
| BODILL, Timothy John | Administrateur | Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton-On-Trent 16 Staffordshire United Kingdom | England | British | 140942610001 | |||||
| BURROWS, Nigel | Administrateur | Greystone Head Kirkby Moor Road Kirkby Malzeard HG4 3RU Ripon N Yorks | British | 35683460001 | ||||||
| CLUTTON, Steven | Administrateur | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 158222570001 | |||||
| COURTLEY, David John | Administrateur | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | 141213480001 | |||||
| FARROW, Matthew James | Administrateur | 34 Lychgate Close LE10 2ES Burbage Leicestershire | England | British | 194105960001 | |||||
| HOWARTH, Mark Edward John | Administrateur | 8 Parsons Grove Denby Village DE5 8PY Ripley Derbyshire | British | 79403870001 | ||||||
| JACKSON, Peter Daniel | Administrateur | The Orchard Main Street Heath S44 5SA Chesterfield Derbyshire | British | 23515580002 | ||||||
| JONES, David Emrys | Administrateur | Biggin House Biggin By Hulland DE6 3FJ Ashbourne Derbyshire | England | English | 211566200001 | |||||
| LLOYD, Neil Anthony | Administrateur | 7 Kenwyn Road SW20 8TR London | England | British | 181988860001 | |||||
| LOCKWOOD, Robert John Harry | Administrateur | 37 The Mount Wrenthorpe WF2 0NZ Wakefield West Yorkshire | British | 111070890001 | ||||||
| MARKE, Nathan Richard | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MARTIN, William Thomas | Administrateur | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 57302660001 | |||||
| MOAKES, Philip | Administrateur | Hall Cliffe Cottage Back Lane, Warslow SK17 0JL Buxton Derbyshire | England | British | 94198370001 | |||||
| MULLER, Neil Keith | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | England | British | 252490400001 | |||||
| PODMORE, Victor Gerald | Administrateur | 12 Middlefield Drive Great Finborough IP14 3AH Stowmarket Suffolk | British | 15200080001 | ||||||
| RILEY, Matthew Robinson | Administrateur | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire England | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| ROBINSON, Nicholas John | Administrateur | Ferry Nab Lane SL7 2EZ Medmanham Ferry Nab England United Kingdom | United Kingdom | British | 54873290006 | |||||
| ROBINSON, Nicholas | Administrateur | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| ROBINSON, Nicholas | Administrateur | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Administrateur | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | 80817560001 | |||||
| SMITH, William Joe | Administrateur | Belstead Old Rectory Copdock IP8 3JS Ipswich Suffolk | England | British | 20327120001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLOUDSURE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Telecoms Limited | 12 juil. 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Daisy It Managed Services Limited | 06 avr. 2016 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CLOUDSURE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 25 oct. 2001 Livré le 07 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 août 1994 Livré le 05 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge supplemental to a debenture | Créé le 19 août 1994 Livré le 05 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture of even date | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 30 juin 1994 Livré le 06 juil. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Servo house bakewell road darley dale matlock derbyshire t/nody 246529. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 31 mars 1992 Livré le 13 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Servo house, littlemoor, eckington, sheffield, N.E.derbyshire. T/no.DY151593 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 août 1987 Livré le 02 sept. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti £210,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Brèves mentions F/H the drill hall, littlemoor, echington, derbyshire. Title no dy 151593. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 30 nov. 1982 Livré le 09 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 07 janv. 1981 Livré le 14 janv. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/Hold 6/10 sheffield road, dronfield, derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0