SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
| Numéro de société | 01428210 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC ?
| Adresse du siège social | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 avr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Adam Derek John Clark en tant que directeur le 30 mars 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Satisfaction de la charge 12 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Nomination de Russell Lee Brown en tant qu'administrateur le 01 mars 2026 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Dean Plowman en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Dennis Andrew Badman en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Thomas Michael John Dillon en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Dean Plowman en tant que secrétaire le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Thomas Michael John Dillon en tant que secrétaire le 31 déc. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2025 | 99 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge 11 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 014282100014 en partie | 4 pages | MR04 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 110 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Patricia Ann Rigby en tant que directeur le 01 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Steven Paul Rigby en tant que directeur le 01 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 014282100015, créée le 14 mars 2024 | 14 pages | MR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 137 pages | AA | ||
Nomination de Mr Dean Plowman en tant qu'administrateur le 11 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Dean Plowman en tant que secrétaire le 11 sept. 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Mark Timothy Nutter en tant que secrétaire le 01 août 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Mark Timothy Nutter en tant que directeur le 01 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Michael Dove en tant que directeur le 08 févr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILLON, Thomas Michael John | Secrétaire | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | 344609480001 | |||||||
| BROWN, Russell Lee | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 346012500001 | |||||
| DILLON, Thomas Michael John | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 344525230001 | |||||
| RIGBY, James Peter | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 88633720016 | |||||
| RIGBY, Peter, Sir | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 15654920006 | |||||
| GARRATT, Georgina Mary | Secrétaire | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | 277149360001 | |||||||
| GILPIN, Nigel Peter | Secrétaire | 172 Widney Lane B91 3LH Solihull West Midlands | British | 42299200003 | ||||||
| GOSSAGE, Neal Trevor | Secrétaire | 20 Cawdell Drive LE12 5BW Long Whatton Leicestershire | British | 79300420001 | ||||||
| HARVEY-CLEWS, Lynda Beatrice | Secrétaire | 16 Belwell Lane Four Oaks B74 4AL Sutton Coldfield West Midlands | British | 72260230002 | ||||||
| MONKS, Terence John | Secrétaire | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | 80344460001 | ||||||
| NUTTER, Mark Timothy | Secrétaire | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | 296181550001 | |||||||
| PLOWMAN, Dean | Secrétaire | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | 313465330001 | |||||||
| RIGBY, James Peter | Secrétaire | The Bell House Old Warwick Road CV35 7BT Rowington Warwickshire | British | 88633720001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secrétaire | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | British | 12470210003 | ||||||
| WILLIAMS, Owen George | Secrétaire | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | British | 138732770001 | ||||||
| BADMAN, Dennis Andrew | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 307246900001 | |||||
| BARRETT, Thomas | Administrateur | 413 Lichfield Road Fouroaks B74 4DJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 44890640001 | ||||||
| BLAND, John | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 124446010001 | |||||
| CLARK, Adam Derek John | Administrateur | Downshire Way Arlington Square RG12 1WA Bracknell Specialist Computer Centre England | England | British | 268559620001 | |||||
| DOVE, Paul Michael | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 98793570001 | |||||
| ECCLESTON, Paul Andrew | Administrateur | 98 Spital Road CH62 2AL Wirral Merseyside | British | 77138480002 | ||||||
| EVERATT, Paul | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | England | British | 60221430002 | |||||
| GILPIN, Nigel Peter | Administrateur | 172 Widney Lane B91 3LH Solihull West Midlands | England | British | 42299200003 | |||||
| LLOYD, Paul | Administrateur | Dundorroch Forest Drive, Kingswood KT20 6LN Tadworth Surrey | British | 83206850001 | ||||||
| LUNCH, Michael Richard | Administrateur | 15 Atwood Little Bookham KT23 3BQ Leatherhead Surrey | England | British | 92383110001 | |||||
| MOYLE, Stephen Glynne | Administrateur | 28 Ferndown Road B91 2AT Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 36649820001 | |||||
| NUTTER, Mark Timothy | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | England | British | 277149320001 | |||||
| PLOWMAN, Dean | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 313465350001 | |||||
| RAYBOULD, Jacqueline Claire | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | England | British | 101106110002 | |||||
| RIGBY, Patricia Ann | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 15557890008 | |||||
| RIGBY, Steven Paul | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | England | British | 41996820011 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Administrateur | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 12470210003 | |||||
| ROVENHALL, Terence Edward | Administrateur | Westeria Cottage Weethley BL9 5NB Alcester Warwickshire | British | 17352960001 | ||||||
| ROWEN, Mary | Administrateur | Hodge Hill B36 8AG Hodge Hill 56 Birmingham England | British | 140989050001 | ||||||
| SCOTT, Ian Peter | Administrateur | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | England | British | 197490770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scc Uk Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Warwick Road B11 2LE Birmingham James House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0