CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED

CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01428872
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hillside Court Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLARKBURGH MANAGEMENT LIMITED13 juin 197913 juin 1979

    Quels sont les derniers comptes de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 24 juil. 2018

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des détails de Jelf Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 sept. 2017

    2 pagesPSC05

    Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Nomination de Marsh Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 10 juil. 2017

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Dawn Jeanette Hodges en tant que secrétaire le 10 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Paul Francis Clayden en tant que directeur le 10 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Caroline Wendy Godwin en tant qu'administrateur le 10 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr James Michael Pickford en tant qu'administrateur le 01 janv. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Edward Barnes en tant que directeur le 31 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 24 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Alexander Douglas Alway en tant que directeur le 11 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alexander Douglas Alway en tant que directeur le 11 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARSH SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Tower Place West
    Tower Place
    EC3R 5BU London
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement555848
    187854670001
    GODWIN, Caroline Wendy
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Administrateur
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    United KingdomBritish224445640001
    PICKFORD, James Michael
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Administrateur
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    United KingdomBritish223405040001
    CLARK, Anne Rosemary
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    Secrétaire
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    British152529010001
    DAVIS, Helen Beatrice
    3 Tollbar Close
    Potterne
    SN10 5PD Devizes
    Wiltshire
    Secrétaire
    3 Tollbar Close
    Potterne
    SN10 5PD Devizes
    Wiltshire
    British77716400001
    HAYWARD, Michael David
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Secrétaire
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    British61397720001
    HODGES, Dawn Jeanette
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Secrétaire
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    203692000001
    ROXBURGH, Malcolm Stuart
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    Secrétaire
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    British7549820001
    ALWAY, Alexander Douglas
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    Administrateur
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    EnglandBritish54126880001
    ALWAY, Alexander Douglas
    Lismore Cheltenham Road
    Bisley
    GL6 7BJ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Lismore Cheltenham Road
    Bisley
    GL6 7BJ Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish54126880001
    ANDREWS, Timothy Lloyd
    4 The Hop Gardens
    Aldington
    WR11 5UB Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    4 The Hop Gardens
    Aldington
    WR11 5UB Evesham
    Worcestershire
    British55942820001
    BARNES, Paul Edward
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Administrateur
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    EnglandBritish176370590001
    BARTON, Philip Andrew
    Church Road
    Yate
    BS37 5JB Bristol
    Fromeforde House
    Avon
    Administrateur
    Church Road
    Yate
    BS37 5JB Bristol
    Fromeforde House
    Avon
    EnglandBritish12624970004
    CARTER, Robert Ross
    48 Albert Park Road
    WR14 1HP Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    48 Albert Park Road
    WR14 1HP Malvern
    Worcestershire
    British94795980002
    CLARK, Anne Rosemary
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    Administrateur
    Glengarry
    2 Ridgeway Road
    BS41 9EU Long Ashton
    North Somerset
    EnglandBritish152529010001
    CLARKE, Colin Raymond
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    Administrateur
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    EnglandBritish11242610001
    CLARKE, Susan Margaret
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    Administrateur
    Westward House
    Hanley Swan
    WR8 0DN Worcester
    United KingdomBritish62400990001
    CLAYDEN, Paul Francis
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    Administrateur
    Tower Place West
    EC3R 5BU London
    1
    England
    United KingdomBritish176795590001
    EGERTON, Simon David
    Drayton House
    62 Hall Green
    WR14 3QX Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    Drayton House
    62 Hall Green
    WR14 3QX Malvern
    Worcestershire
    British11428940003
    HARDING, John Trevor
    Martindale
    Bridgewater Road
    BS25 1NN Sidcot
    North Somerset
    Administrateur
    Martindale
    Bridgewater Road
    BS25 1NN Sidcot
    North Somerset
    EnglandBritish99783690002
    HAYWARD, Michael David
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    21 Jubilee Drive
    Bredon
    GL20 7QJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish61397720001
    JAMES, Barrie Stuart
    3 Allsebrook Gardens
    Badsey
    WR11 5HJ Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    3 Allsebrook Gardens
    Badsey
    WR11 5HJ Evesham
    Worcestershire
    British47100390002
    JENKINS, Brian Edward
    Oaklands Picken End
    Hanley Swan
    WR8 0DQ Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Oaklands Picken End
    Hanley Swan
    WR8 0DQ Worcester
    Worcestershire
    British11428950001
    NEVITT, Mark Christopher
    Stockcross
    RG20 8LH Newbury
    Wenlock House
    Berkshire
    Administrateur
    Stockcross
    RG20 8LH Newbury
    Wenlock House
    Berkshire
    EnglandBritish138144910001
    RICHMOND, Charles Keenan
    10 Earlsdon Road
    Hanbury Park
    WR2 4PF Worcester
    Hereford & Worcestershire
    Administrateur
    10 Earlsdon Road
    Hanbury Park
    WR2 4PF Worcester
    Hereford & Worcestershire
    British16688990002
    ROXBURGH, Kay Vanessa
    The Steppings, Bosbury Road
    WR13 5JA Cradley Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    The Steppings, Bosbury Road
    WR13 5JA Cradley Malvern
    Worcestershire
    United KingdomBritish110138100001
    ROXBURGH, Malcolm Stuart
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    The Steppings Bosbury Road
    Cradley
    WR13 5JA Malvern
    Worcestershire
    EnglandBritish7549820001
    WILLIS, James
    Walkwood Farm
    Morton Lane Walkwood
    B97 5QA Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    Walkwood Farm
    Morton Lane Walkwood
    B97 5QA Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish16677940002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Jelf Limited
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    06 avr. 2016
    Bowling Hill
    Chipping Sodbury
    BS37 6JX Bristol
    Hillside Court
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement2975376
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Bowling Hill
    BS37 6JX Chipping Sodbury
    Hillside Court
    Bristol
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Bowling Hill
    BS37 6JX Chipping Sodbury
    Hillside Court
    Bristol
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2975376
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CLARKE ROXBURGH INSURANCE BROKERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 févr. 2010
    Livré le 18 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aviva Insurance UK Limited (Aviva), Sun Alliance Insurance Overseas Limited (Rsa), Allianz Holdings PLC (Allianz)
    Transactions
    • 18 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 28 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture by the company and kelquota limited
    Créé le 13 mars 1998
    Livré le 20 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement (as therein defined) or otherwise
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 24 belle vue terrace malvern, 8 church green east redditch west midlands, 15 foregate street worcester (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cornhill Insurance PLC
    Transactions
    • 20 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 25 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0