KUNICK (109) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKUNICK (109) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01434201
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KUNICK (109) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KUNICK (109) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KUNICK (109) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GAMESTEC LEISURE LIMITED02 déc. 200202 déc. 2002
    KUNICK LEISURE LIMITED09 févr. 199609 févr. 1996
    MUSIC HIRE GROUP LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980

    Quels sont les derniers comptes de KUNICK (109) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 oct. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KUNICK (109) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KUNICK (109) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    27 pages4.72

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 avr. 2013

    29 pages2.24B

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    25 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    7 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* le 15 nov. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    4 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2012

    État du capital au 20 août 2012

    • Capital: GBP 90,496,864.88
    SH01

    Cessation de la nomination de Christopher Butler en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Brown en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Leisure Connection Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom* le 20 août 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Horsforth Mills Low Lane Horsforth LS18 4ER* le 03 août 2012

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 01 oct. 2011

    31 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Butler en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Brown en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed gamestec leisure LIMITED\certificate issued on 25/07/12
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name25 juil. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de KUNICK (109) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    NICHOLLS, Julian Frederick
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    c/o Danoptra Limited
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish95086050001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Administrateur
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    BAILEY, Geoffrey Raw
    5 Norgarth Close
    Soothill
    WF17 6HF Batley
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Norgarth Close
    Soothill
    WF17 6HF Batley
    West Yorkshire
    British49609920001
    BROWN, Andrew Paul
    56 Bank Crest
    BD17 5HB Baildon
    West Yorkshire
    Administrateur
    56 Bank Crest
    BD17 5HB Baildon
    West Yorkshire
    United KingdomBritish126397230001
    BUTLER, Christopher Michael
    Weaverlake Drive
    Yoxall
    DE13 8AD Burton-On-Trent
    Byron House
    Staffordshire
    Administrateur
    Weaverlake Drive
    Yoxall
    DE13 8AD Burton-On-Trent
    Byron House
    Staffordshire
    EnglandBritish146447120001
    COPPIN, Alan Charles
    Briar Hedge
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Briar Hedge
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82808900001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    EVANS, Wayne David
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    Administrateur
    4 Arncliffe Way
    HU16 5DH Cottingham
    North Humberside
    United KingdomBritish118359700001
    HODKIN, David Arthur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    Administrateur
    27 Nettleham Road
    LN2 1RQ Lincoln
    United KingdomBritish40702370002
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Administrateur
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    JOHNSON, Alex
    40 Moorway
    Guiseley
    LS20 8LD Leeds
    Administrateur
    40 Moorway
    Guiseley
    LS20 8LD Leeds
    EnglandBritish213648130001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish71715970001
    LLOYD, Derek Thomas
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    Administrateur
    55 Westerdale Drive
    Banks
    PR9 8DG Southport
    Merseyside
    EnglandEnglish98695040001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130608590001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Administrateur
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish57198790001
    NIELSEN, Rolf
    7 Autumn Crescent
    LS18 4HT Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Autumn Crescent
    LS18 4HT Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish50980130003
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Richard Stephen
    26 Lascelles Hall Road
    Lascelles Hall
    HD5 0AU Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    26 Lascelles Hall Road
    Lascelles Hall
    HD5 0AU Huddersfield
    West Yorkshire
    British54147940001
    SMITH, Russell Stansfield
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    Administrateur
    64 Riverside Court
    Victoria Road
    BD18 3LZ Shipley
    Saltaire
    British809230004
    WALTERS, Philip Donald
    Flat 5
    16 Mount Row
    W1K 3SE London
    Administrateur
    Flat 5
    16 Mount Row
    W1K 3SE London
    United KingdomBritish78370620002
    WOOD, Russell Stephen
    Yew Tree House
    29 Yew Tree Road
    HD3 3QT Bichencliffe Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yew Tree House
    29 Yew Tree Road
    HD3 3QT Bichencliffe Huddersfield
    West Yorkshire
    British64853900002

    KUNICK (109) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 13 mars 2012
    Livré le 21 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £43,750 plus vat.. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Computacenter (UK) Limited
    Transactions
    • 21 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge of deposit
    Créé le 18 nov. 2011
    Livré le 24 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit of £23,000 and all amounts in the future credited to account number 46214410 with the bank.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge of deposit
    Créé le 07 avr. 2011
    Livré le 12 avr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit of £177,255 and all amounts in the future credited to account number 46040943 with the bank. Note: the charge contains a covenant by the company that the company will not permit or create any mortgage charge or lien on the deposit or dispose of or assign the deposit.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 oct. 2009
    Livré le 06 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £70793.75 and all sums paid to the landlord under the terms of the rent deposit deed see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Computacenter (UK) Limited
    Transactions
    • 06 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 31 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Bank account charge and receivables assignment
    Créé le 20 août 2009
    Livré le 21 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the charged accounts and the bank balances, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse, London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 21 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 19 août 2008
    Livré le 22 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and the derivative assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse the Security Trustee
    Transactions
    • 22 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 19 août 2008
    Livré le 21 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse, London Branch (Security Trustee)
    Transactions
    • 21 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002
    Créé le 09 févr. 2004
    Livré le 25 févr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the newly acquired properties together with all buildings fixtures fixed plany and machinery, being all that f/h property known as the maltings wetmore road burton on trent t/n SF47581,the f/h property known as the old granary wetmore road burton on trent t/n SF4757750, the f/h property known as unit 51 hutton close, crowther industrial estate washington sunderland tyne & wear t/n TY202817.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 22 may 2002 and
    Créé le 13 août 2002
    Livré le 22 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee and/or the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK588050 and f/h property k/a miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/no. WYK48128. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 13 août 2002
    Livré le 21 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all that freehold property known as main warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK588050. All that freehold property known as miles warehouse, low lane, horsfield, leeds t/n WYK48128, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 1992
    Livré le 18 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a composite guarantee and debenture dated 12/10/92
    Brèves mentions
    F/H property near the railway station pewsey wilts.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Banks
    Transactions
    • 18 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 oct. 1992
    Livré le 21 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the "debenture"
    Brèves mentions
    Land at automat house aqueduct road,blackburn,lancashire title number LA404853 see doc ref M554C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcand Each of the Banksin Its Capacity as Agent and Trustee for Itself
    Transactions
    • 21 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & trust debenture
    Créé le 06 mars 1991
    Livré le 20 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the floating documents
    Brèves mentions
    Various properties as specified in from 395 reg: m 76.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plce Governor and Company of the Bank of Scotland).(For Itself National Westminster Bank PLC and Th
    Transactions
    • 20 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 déc. 1990
    Livré le 21 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 22 janv. 1986
    Livré le 04 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the items of equipment described in the schedule attached to the charge (see doc for full details).
    Personnes ayant droit
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 22 janv. 1986
    Livré le 28 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Second fixed charge on all bookdebts & other debts. (See doc M57 for full details,).
    Personnes ayant droit
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Floating charbge
    Créé le 22 janv. 1986
    Livré le 28 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1986
    Livré le 23 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (1) l/h premises company a warehouse at yeadon near leeds. T/no - 227594 (2) l/h unit 1, the perivale new business centre, perivale, middx (see doc M54 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Release and debenture mortgage
    Créé le 22 janv. 1986
    Livré le 23 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge supplemental to a chattel mortgage dated 9-3-82
    Brèves mentions
    All and singular us item or items of equipment described in the schedule to the charge which are described as the additional items in the charge.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1986
    Livré le 28 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/hold & l/hold properties as more fully described in doc M55 and continuation sheet attached. (See doc M55 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Kunick Leisure Group PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Release and further mortgage
    Créé le 25 juil. 1985
    Livré le 29 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a chattel mortgage dated 9/3/82 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    All and singular the items of equipment as listed in the schedule to the deed together with any other item or items of equipment as may be designated by midland bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Release and further charge
    Créé le 29 mars 1985
    Livré le 02 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing all moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a chattel mortgage dated 9/3/82.
    Brèves mentions
    All the singular items of equipment listed on the schedule to the release and further mortgage together with any other item or items of equipment as may be designated) by midland bank bank PLC ("the chattel") (see schedule for details.).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    Release and further mortgage
    Créé le 26 oct. 1984
    Livré le 31 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due under a chattel mortgage 9.3.82 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    All and singular the items of equipment as listed in the schedule together with any other items or equipment as may be designated by midland bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Release and further mortgage
    Créé le 29 juin 1984
    Livré le 04 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing all moneys due or to become due (defined in the chattel mortgage dated 9/3/82) due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All and singular the items of equipment listed on the schedule attached to the release and further mortgage together with any other items or item of equipment as may be designated by midland bank PLC ("the chattel").
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    Release and further mortgage
    Créé le 15 mars 1984
    Livré le 16 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due (defined in the chattel mortgage dated 9/3/82) from the company to the chargee or any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the items of equipment listed on the schedule attached to the release and further mortgage together with any other item or items of equipment as may be designated by midland bank PLC (the chattel).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1984Enregistrement d'une charge

    KUNICK (109) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 nov. 2012Administration started
    03 avr. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DateType
    03 avr. 2013Commencement of winding up
    04 mai 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0