CHAMELEON TELEVISION LIMITED

CHAMELEON TELEVISION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHAMELEON TELEVISION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01436148
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    • Activités de production de programmes de télévision (59113) / Information et communication

    Où se situe CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Wellroyd Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    West Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHAMELEON FILM SERVICES LIMITED 10 juil. 197910 juil. 1979

    Quels sont les derniers comptes de CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de 23 South View Terrace Yeadon Leeds West Yorkshire LS19 7QL à 2 Wellroyd Knott Lane Rawdon Leeds West Yorkshire LS19 6JW le 03 janv. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2016

    État du capital au 06 janv. 2016

    • Capital: GBP 52,798
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Sophie Ellis-Hudson le 11 août 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Sophie Ellis-Hudson en tant qu'administrateur le 11 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Stephen Alexander Kirkbright en tant que directeur le 11 août 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew Hudson en tant que secrétaire le 11 août 2015

    2 pagesAP03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Knott House Knott Lane Rawdon Leeds West Yorkshire LS19 6JW à 23 South View Terrace Yeadon Leeds West Yorkshire LS19 7QL le 07 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard Everiss en tant que secrétaire le 11 août 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Allen John Wentworth Jewhurst en tant que directeur le 08 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Everiss en tant que directeur le 11 août 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2015

    État du capital au 15 janv. 2015

    • Capital: GBP 52,798
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 déc. 2013

    État du capital au 31 déc. 2013

    • Capital: GBP 52,798
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    legacy

    6 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUDSON, Andrew
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    2 Wellroyd
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    2 Wellroyd
    West Yorkshire
    England
    200795380001
    ELLIS, Sophie
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    2 Wellroyd
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    2 Wellroyd
    West Yorkshire
    England
    EnglandEnglishJournalist200796230002
    EVERISS, Richard
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    Knott House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    Knott House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    BritishProduction Manager67917220001
    REEVE, Mark Andrew Peter
    Elrig
    16 Kent Road
    HG1 2LE Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Elrig
    16 Kent Road
    HG1 2LE Harrogate
    North Yorkshire
    British35460210002
    BRILL, Anthony George
    11 Manor Farm Close
    Copmanthorpe
    YO23 3GE York
    North Yorkshire
    Administrateur
    11 Manor Farm Close
    Copmanthorpe
    YO23 3GE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director67617000001
    COYLE, Ralph John
    8 Grange View
    LS21 2SE Otley
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Grange View
    LS21 2SE Otley
    West Yorkshire
    BritishDirector44358890001
    EVERISS, Richard
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    Knott House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    Knott House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishProduction Consultant67917220002
    FAIRLEY, John Alexander
    Trainers House
    Eddlethorpe
    YO17 9QS Malton
    North Yorkshire
    Administrateur
    Trainers House
    Eddlethorpe
    YO17 9QS Malton
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector Of Programmes45571660001
    FRASER, David Richard
    17 Rathen Road
    M20 4QJ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    17 Rathen Road
    M20 4QJ Manchester
    Lancashire
    BritishDirector30040490001
    GREGORY, Richard John
    Brooklands, 115 Castleton Road
    Hope
    S33 6SB Hope Valley
    Derbyshire
    Administrateur
    Brooklands, 115 Castleton Road
    Hope
    S33 6SB Hope Valley
    Derbyshire
    BritishDirector26315510001
    GREGORY, Richard John
    Brooklands, 115 Castleton Road
    Hope
    S33 6SB Hope Valley
    Derbyshire
    Administrateur
    Brooklands, 115 Castleton Road
    Hope
    S33 6SB Hope Valley
    Derbyshire
    BritishDirector26315510001
    HARRIS, Brian Frederick John
    1 Oakdale Drive
    Pool In Wharfedale
    LS21 1LJ Otley
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Oakdale Drive
    Pool In Wharfedale
    LS21 1LJ Otley
    West Yorkshire
    BritishDirector Of Business Affairs47829930001
    HOLDGATE, David Kenneth
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector23170560002
    HOLDGATE, David Kenneth
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    28 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector23170560002
    JEWHURST, Allen John Wentworth
    Knott House
    Knott Lane Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Knott House
    Knott Lane Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishFilm Producer34509650001
    KIRKBRIGHT, John Stephen Alexander
    48 The Balk
    Walton
    WF2 6JU Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    48 The Balk
    Walton
    WF2 6JU Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishSolicitor7356730001
    LINACRE, John Gordon Seymour, Sir
    White Windows Staircase Lane
    Bramhope
    LS16 9JD Leeds
    Administrateur
    White Windows Staircase Lane
    Bramhope
    LS16 9JD Leeds
    United KingdomBritishPublisher6425600001
    LOWEN, David Travers
    41 Batcliffe Drive
    LS6 3QB Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    41 Batcliffe Drive
    LS6 3QB Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector13822190001
    LOWEN, David Travers
    41 Batcliffe Drive
    LS6 3QB Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    41 Batcliffe Drive
    LS6 3QB Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector13822190001
    SURTEES, John Douglas
    1 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector44846400002
    WHISTON, John Joseph
    68 Stamford Road
    WA14 2JF Bowdon
    Cheshire
    Administrateur
    68 Stamford Road
    WA14 2JF Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritishDirector57313510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHAMELEON TELEVISION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Sophie Ellis-Hudson
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    2 Wellroyd
    West Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Knott Lane
    Rawdon
    LS19 6JW Leeds
    2 Wellroyd
    West Yorkshire
    England
    Non
    Nationalité: English
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CHAMELEON TELEVISION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A charge
    Créé le 15 févr. 2013
    Livré le 20 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the borrower's right title benefit and interest to and in the same including without limitation any and all sums of money whatever payable to or on account of the borrower by itv pursuant to the itv contract see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge
    Créé le 08 oct. 2012
    Livré le 10 oct. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge right title and interest in all those assets, the programme provisionally entitled "perspectives: warwick davis", the proceeds of the insurance policies and by way of floating charge all of its assets and undertaking see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge
    Créé le 17 févr. 2012
    Livré le 21 févr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in and to the rights the itv contract and the benefit of the insurance policies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2011
    Livré le 10 janv. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 1990
    Livré le 16 févr. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0