TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST

TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 01438582
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST ?

    • (9305) /

    Où se situe TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST ?

    Adresse du siège social
    Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    29 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2023

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2022

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2022

    24 pagesLIQ03

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    pages2.34B

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2022

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2015

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2021

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2021

    22 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2021

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2020

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2020

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2020

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2019

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2019

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2019

    5 pages4.68

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    9 pagesLIQ10

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2018

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2018

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2018

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2017

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2017

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 juin 2017

    5 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:secretary of states' release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Qui sont les dirigeants de TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEMPSEY, Michael Basil
    59 Cephas Avenue
    E1 4AR London
    Secrétaire
    59 Cephas Avenue
    E1 4AR London
    British21434700001
    COOPER, Caroline Louise
    Egerton House 41 Egerton Drive
    SE10 8JR London
    Administrateur
    Egerton House 41 Egerton Drive
    SE10 8JR London
    EnglandBritish76694480001
    DEMPSEY, Michael Basil
    59 Cephas Avenue
    E1 4AR London
    Administrateur
    59 Cephas Avenue
    E1 4AR London
    British21434700001
    EVANS, Caroline
    27 Egerton Drive
    Greenwich
    SE10 8JR London
    Administrateur
    27 Egerton Drive
    Greenwich
    SE10 8JR London
    EnglandBritish51598940001
    FOX, Nick, Dr
    292 Globe Road
    E2 0NS London
    Administrateur
    292 Globe Road
    E2 0NS London
    British53763420001
    KHALDI, Saad
    2 Vicars Close
    Hackney
    E9 7HT London
    Administrateur
    2 Vicars Close
    Hackney
    E9 7HT London
    British83911160001
    NOBLE, Maria Rosario
    6 Moravian Street
    E2 0NJ London
    Administrateur
    6 Moravian Street
    E2 0NJ London
    EnglandBritish,Spanish106283980001
    RAHMAN, Mothiur
    Hamilton Road
    SE27 9SE London
    127
    Administrateur
    Hamilton Road
    SE27 9SE London
    127
    British129859720001
    ROBERTS, Rowena Jane
    14 Cressy Houses
    Hannibal Road
    E1 3JE London
    Administrateur
    14 Cressy Houses
    Hannibal Road
    E1 3JE London
    EnglandBritish121947530001
    STREETER, Patrick Thomas
    Watermans End Cottage
    Matchinggreen
    CM17 0RQ Harlow
    Essex
    Administrateur
    Watermans End Cottage
    Matchinggreen
    CM17 0RQ Harlow
    Essex
    United KingdomBritish52062800001
    AHMED, Tassaduq
    101 Praed Street
    W2 1NT London
    Administrateur
    101 Praed Street
    W2 1NT London
    British35531490002
    ALAM, Shamsul
    282 Globe Road
    E2 0NS London
    Administrateur
    282 Globe Road
    E2 0NS London
    EnglandBritish60078700001
    ALI, Roshanara
    Not Available
    Administrateur
    Not Available
    British77932470002
    BARLOW, Lesley Grace
    Chingwood
    20 Silver Birch Avenue
    CM16 6LB Epping
    Essex
    Administrateur
    Chingwood
    20 Silver Birch Avenue
    CM16 6LB Epping
    Essex
    United KingdomBritish80243610001
    BARLOW, Paul
    19 Redriffe Road
    Plaistow
    E13 0JX London
    Administrateur
    19 Redriffe Road
    Plaistow
    E13 0JX London
    British77653230002
    BEGUM, Halina
    20 Orion House
    Coventry Road
    E1 5RX London
    Administrateur
    20 Orion House
    Coventry Road
    E1 5RX London
    British57565520002
    BRYANT, Colin
    174 Sunnyhill Road
    Streatham
    SW16 2UN London
    Administrateur
    174 Sunnyhill Road
    Streatham
    SW16 2UN London
    British21434750001
    COLLINS, Lilian Margaret
    1 Clutton Street
    E14 6QN London
    Administrateur
    1 Clutton Street
    E14 6QN London
    British21434770001
    CROOKSTON, Peter Martin
    43 Beversbrook Road
    N19 4QQ London
    Administrateur
    43 Beversbrook Road
    N19 4QQ London
    United KingdomBritish11517180002
    DAVIS, Maureen
    38 Rum Close
    Wapping
    E1W 3QX London
    Administrateur
    38 Rum Close
    Wapping
    E1W 3QX London
    British55001840003
    DEEMING, Dorothy Florence
    34 Portree Street
    E14 0HT London
    Administrateur
    34 Portree Street
    E14 0HT London
    British21434730001
    GADD, Derek John
    2 Cloysters Green
    E1W 1LU London
    Administrateur
    2 Cloysters Green
    E1W 1LU London
    British99407690001
    GOODRICH, Siobhan Catherine
    27 Trinity Green
    E1 4TS London
    Administrateur
    27 Trinity Green
    E1 4TS London
    British29216350001
    JACOB, Albert
    11 Paradise Row
    E2 9LE London
    Administrateur
    11 Paradise Row
    E2 9LE London
    British11270280001
    JOHNSON, Diana Ruth
    13 Malam Gardens
    E14 0TR London
    Administrateur
    13 Malam Gardens
    E14 0TR London
    British95375120001
    LOAN, Leonard
    9 Exmoor House
    E3 5DW London
    Administrateur
    9 Exmoor House
    E3 5DW London
    British21434760001
    ROGERS, Lesley Angela
    4 Sutton Place
    Hackney
    E9 6EH London
    Administrateur
    4 Sutton Place
    Hackney
    E9 6EH London
    EnglandBritish94031940001
    STOAKES, Barbara Diana
    Forge Cottage Bayham Abbey
    Lamberhurst
    TN3 8BG Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Forge Cottage Bayham Abbey
    Lamberhurst
    TN3 8BG Tunbridge Wells
    Kent
    British58526230002
    TODD, Mary
    32 Cephas Avenue
    E1 4AT London
    Administrateur
    32 Cephas Avenue
    E1 4AT London
    British105000200001

    TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 03 nov. 2008
    Livré le 04 nov. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land to the west of park grange road, sheffield t/no SYK543078. Floating charge over all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank PLC
    Transactions
    • 04 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2008Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
      • Numéro de dossier 3
    Charge
    Créé le 04 déc. 2007
    Livré le 05 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    4 pinchin st,london E1 1SA; all fixed and floating assets.
    Personnes ayant droit
    • Sme Wholesale Finance (London) LTD
    Transactions
    • 05 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 24 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hold property known as norfolk park,sheffield; SYK526614. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2008Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
      • Numéro de dossier 2
    Legal charge
    Créé le 28 août 2007
    Livré le 29 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    4 pinchin street london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 2007
    Livré le 05 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    £100,000 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Land at railway arches bancroft road london t/n EGL520045 all liens and charges over the property proceeds of sale and all buildings and fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Adventure Capital Fund
    Transactions
    • 05 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2007
    Livré le 17 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 19 oct. 2005
    Livré le 02 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H units 1-10 pinchin and johnson's yard,pinchin street,london.t/n EGL322075. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 oct. 2005
    Livré le 02 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H 32 chilcott avenue,brynmenyn industrial estate,bridgend.t/n CYM147504. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 2004
    Livré le 03 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property at units 1 to 10 pinchin and johnson's yard pinchin street london t/no EGL322075. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2004
    Livré le 20 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 déc. 1997
    Livré le 19 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £1,065,000 under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Units 1-10 pinchin & johnson's yard pinchin street t/no;-EGL322075 goodwill of business at the property and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank
    Transactions
    • 19 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 1997
    Livré le 19 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £1,065,000 under the terms of the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank
    Transactions
    • 19 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 nov. 1997
    Livré le 13 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £1,065,000.00
    Brèves mentions
    Part of the property known as land at congleton grove, the oaks, plumstead title number 117023 and 116755. floating charge over the equipment unfixed plant machinery. Benefit of any licences, goodwill of any business.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 sept. 1997
    Livré le 19 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south east side of victoria crescent lambeth t/no tgl 129253 and a and assigns the goodwill of the business and the benefit of the licence. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Unity Trust Bank
    Transactions
    • 19 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 avr. 1994
    Livré le 18 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 1994
    Livré le 15 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £130,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H property at 1-10 pinchin and johnsons yard pinchin street london E1.
    Personnes ayant droit
    • Mercury Provident PLC
    Transactions
    • 15 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 nov. 1990
    Livré le 19 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge not exceeding £1,700,000
    Brèves mentions
    F/H land & buildings at royston street bonner street, hunslett street and hartley street, london E2.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich Building Society
    Transactions
    • 19 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TOWER HAMLETS ENVIRONMENT TRUST a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 déc. 2008Administration started
    07 juin 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin John Atkins
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London N20 0yz
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London N20 0yz
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Anthony Long
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    receiver manager
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    Alan Scanlon Murdoch
    Stevens Scanlan
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    receiver manager
    Stevens Scanlan
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Anthony Long
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    receiver manager
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    Alan Scanlon Murdoch
    Stevens Scanlan
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    receiver manager
    Stevens Scanlan
    73 Mosley Street
    M2 3JN Manchester
    4
    DateType
    07 juin 2010Commencement of winding up
    07 nov. 2023Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin John Atkins
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London N20 0yz
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London N20 0yz
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    John Dean Cullen
    2 Sovereign Quay Havannah Street
    CF10 5SF Cardiff
    South Glamorgan
    practitioner
    2 Sovereign Quay Havannah Street
    CF10 5SF Cardiff
    South Glamorgan
    Bethan Louise Evans
    2 Sovereign Quay Havannah Street
    CF10 5SF Cardiff
    South Glamorgan
    practitioner
    2 Sovereign Quay Havannah Street
    CF10 5SF Cardiff
    South Glamorgan

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0