BEPCO AGRI LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBEPCO AGRI LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01440643
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BEPCO AGRI LIMITED ?

    • Commerce de gros de machines, équipements et fournitures agricoles (46610) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe BEPCO AGRI LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BEPCO AGRI LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BEPCO (UK) LIMITED05 avr. 199105 avr. 1991
    MIFFLIN TRADING LIMITED30 juil. 197930 juil. 1979

    Quels sont les derniers comptes de BEPCO AGRI LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BEPCO AGRI LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BEPCO AGRI LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2014

    État du capital au 16 juil. 2014

    • Capital: GBP 301,000
    SH01

    Comptes établis au 30 sept. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 27 juin 2013

    SH01

    Comptes établis au 30 sept. 2012

    17 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bepco (uk) LIMITED\certificate issued on 01/02/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 févr. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Keith Palmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Amanda Wood en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Keith Palmer en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 sept. 2012

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Edward Salter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Salvo Mazzotta en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Giorgio Fioranelli en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Pascal Vanhalst en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Bernard De Meester en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BEPCO AGRI LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOOD, Amanda
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Secrétaire
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    174129600001
    DE MEESTER, Bernard Stephan
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Administrateur
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    BelgiumBelgianDirector168959600001
    VANHALST, Pascal
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Administrateur
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    BelgiumBelgianDirector168959780001
    BAINTON, Adrian Richard
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    BritishDirector14830800001
    FRY, Wendy Kristina
    14 Comfrey Close
    RG40 5YN Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    14 Comfrey Close
    RG40 5YN Wokingham
    Berkshire
    British51725180001
    HOW, David Alfred George
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    British36176510001
    MIFFLIN, Marion Geraldine
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Secrétaire
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    British14318020001
    PALMER, Keith
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    Secrétaire
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    BritishDirector79386550001
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Secrétaire
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    BritishAccountant49339260001
    ANGEL, Jeremy
    50 Meole Rise
    SY3 9JF Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    50 Meole Rise
    SY3 9JF Shrewsbury
    Salop
    BritishSales Director71195330001
    ASKHAM, Francis Guy Lewis
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Spinney Corner Church Lane
    Braishfield
    SO51 0QH Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Accountant15237500001
    BAINTON, Adrian Richard
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    Administrateur
    2 Oak Drive
    Burghfield Common
    RG7 3JF Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector14830800001
    BENCE, John Albert
    25 Oakdene
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    25 Oakdene
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector69524150001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Administrateur
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    BritishMathematician73554610001
    BRENTNALL, Trevor Alan
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    Administrateur
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    BritishSolicitor39686000001
    BRETT, Jamie
    Cwmma Green Cottage
    Brilley
    HR3 6JP Whitney On Wye
    Herefordshire
    Administrateur
    Cwmma Green Cottage
    Brilley
    HR3 6JP Whitney On Wye
    Herefordshire
    BritishSales Director77234080001
    BREWIN, Peter Ronald
    Nutwood House
    The Street
    TN15 0QE Plaxtol
    Sevenoaks Kent
    Administrateur
    Nutwood House
    The Street
    TN15 0QE Plaxtol
    Sevenoaks Kent
    BritishChartered Engineer45850380001
    BROWN, Robert Martin
    81 Browning Road
    Grantley Park Church Crookham
    GU52 0YY Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    81 Browning Road
    Grantley Park Church Crookham
    GU52 0YY Fleet
    Hampshire
    BritishFinance Director75375360001
    FIORANELLI, Giorgio
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Administrateur
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    ItalyItalianDirector163032950001
    GIORDANO, Amanda Jayne
    Maesmellan
    New Radnor
    LD8 2TN Presteigne
    Powys
    Administrateur
    Maesmellan
    New Radnor
    LD8 2TN Presteigne
    Powys
    BritishDirector14318030001
    HEYNEKER, Gerardus James
    24 Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    24 Fox Lane
    Oakley
    RG23 7BB Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector16423710001
    HOW, David Alfred George, Mr.
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Michaelmas Fair
    Ashdon
    CB10 2JE Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishChartered Secretary21860001
    HOWAT, James Anthony
    Lea Farmhouse
    Bishops Offley
    ST21 6EU Stafford
    Administrateur
    Lea Farmhouse
    Bishops Offley
    ST21 6EU Stafford
    UkBritishDirector41852290001
    LITWINOWICZ, Leszek Richard
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    72 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector70815770002
    MAZZOTTA, Salvo
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    Administrateur
    Bepco House
    316 Hartlebury Trading Estate
    DY10 4JB Hartlebury
    Worcestershire
    UsaItalianDirector163043060001
    MIDDLETON, Trevor
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    Administrateur
    High House
    Old Warwick Road
    CV35 7AA Rowington
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector221486370001
    MIFFLIN, Marion Geraldine
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Administrateur
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    BritishDirector14318020001
    MIFFLIN, Philip George Thomas
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    Administrateur
    The Arles
    16 Greenfield Drive
    HR5 3AD Kington
    Herefordshire
    BritishDirector14318070001
    PALMER, Keith
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    Administrateur
    Bute House
    Hill Lane
    WR10 3HU Elmley Castle
    Worcestershire
    EnglandBritishAccountant79386550001
    SALTER, Edward John
    Devon Road
    WV1 4BE Wolverhampton
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Devon Road
    WV1 4BE Wolverhampton
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant87426020002
    STREATFIELD, Paul Richard
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    45 Castle Lane
    Chandlers Ford
    SO53 4AH Eastleigh
    Hampshire
    BritishDirector49339260001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    BritishDirector19140250001

    BEPCO AGRI LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 19 févr. 2007
    Livré le 22 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv
    Transactions
    • 22 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 17 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a or being unit 2 hatton gardens industrial estate kington herefordshire HR5 3RB. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust debenture
    Créé le 17 oct. 2002
    Livré le 23 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company as an obligor to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited
    Transactions
    • 23 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 janv. 1998
    Livré le 27 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to midland bank PLC including all monies, obligations and liabilities, due owing or incurred under or pursuant to the secured documents (as defined) and irrevocably and unconditionally guarantees the due performance by each other company of all it's obligations under or pursuant to the secured documents to which it is a party
    Brèves mentions
    For full details of all charged assets please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 05 avr. 1991
    Livré le 09 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital. Those mentioned above).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 26 janv. 1989
    Livré le 03 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on book debts
    Créé le 21 août 1986
    Livré le 28 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 sept. 1984
    Livré le 05 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a facility letter dated 9/7/84 and the guarantee dated 17/8/84
    Brèves mentions
    F/H land comprising of 0.59 an acre (0.238 hectares) or thereabouts together with the premises erected thereon unit 2,hatton garden industrial estate, kington in the county of hereford & worcester.
    Personnes ayant droit
    • English Industrial Estates Corporation.
    Transactions
    • 05 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0