SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01446230 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Merseyside |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de North Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE13 9AA à 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH le 05 janv. 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 15 août 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Victoria Louise Bradin le 01 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Victoria Louise Bradin en tant qu'administrateur le 16 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Brendan Peter Flattery en tant que directeur le 16 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Parry en tant qu'administrateur le 18 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alastair John Mitchell en tant que directeur le 18 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Parry en tant que secrétaire le 31 juil. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Louise Hall en tant que secrétaire le 31 juil. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARRY, Mark | Secrétaire | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | 190499030001 | |||||||
BRADIN, Victoria Louise | Administrateur | NE13 9AA Newcastle Upon Tyne North Park United Kingdom | United Kingdom | British | General Counsel And Company Secretary | 214451730001 | ||||
PARRY, Mark | Administrateur | Princes Parade L3 1QH Liverpool 8 Merseyside | United Kingdom | British | Solicitor | 198658460001 | ||||
BYRNE, Paul Bernard | Secrétaire | 32 Castlebar Park Ealing W5 1BU London | British | 1450630001 | ||||||
HALL, Louise | Secrétaire | Beechgrove Acklington NE65 9BY Morpeth Northumberland | British | 77212940004 | ||||||
JOHNSTON, Alistair James | Secrétaire | 2 Syon Park Gardens TW7 5NB Isleworth Middlesex | British | 115073570001 | ||||||
NEEDHAM, Janet Susan | Secrétaire | Woodview Gregory Road SL2 3XL Hedgerley Buckinghamshire | British | Finance Director | 77105480001 | |||||
POYSER, David Charles | Secrétaire | 4 Rose Hill RH4 2EG Dorking Surrey | British | Financial Controller | 147187260001 | |||||
SCHOFIELD, Alan Donald | Secrétaire | 1 Summerhill Avenue NE3 5QJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 115685980001 | ||||||
STEINGOLD, Lawrence Gerald | Secrétaire | Flat 33 20 Lawn Lane Vauxhall SW8 1GA London | British | Vice President Finance & Opera | 96504890001 | |||||
BAILEY, Stephen Paul | Administrateur | 99 Chapman Square Parkside Wimbledon Common SW19 5QW London | British | Managing Director | 86511990001 | |||||
BREARLEY, John Richard | Administrateur | 39 Beverley Terrace Cullercoats NE30 4NU North Shields Tyne & Wear | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 114980350001 | ||||
BYRNE, Paul Bernard | Administrateur | 32 Castlebar Park Ealing W5 1BU London | British | International Director | 1450630001 | |||||
COOKE, Roderick William Cameron | Administrateur | The Old Vicarage Long Crendon Road OX9 3AB Thame Oxfordshire | British | Company Director | 1457260001 | |||||
CRITCHLOW, Robert Howard | Administrateur | Weybourne Nuns Walk GU25 4RT Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 48964050002 | ||||
DOWLING, Sean Francis | Administrateur | Cranes Farm House East Garston RG16 7HU Newbury Berkshire | Great Britain | British | Managing Director | 1450640002 | ||||
FLATTERY, Brendan Peter | Administrateur | North Park Newcastle Upon Tyne NE13 9AA Tyne & Wear | United Kingdom | British | Managing Director | 168203410001 | ||||
GASS, Andrew | Administrateur | 1 Ashdown Way Kingwood RG9 5WD Henley On Thames Oxfordshire | England | British | Managing Director | 49358720003 | ||||
GEARY, Karen Mary | Administrateur | The Coach House Sandhoe NE46 4LU Corbridge Northumberland | United Kingdom | British | Company Director | 74821590001 | ||||
JOHNSTON, Alistair James | Administrateur | 2 Syon Park Gardens TW7 5NB Isleworth Middlesex | United Kingdom | British | Financial Director | 115073570001 | ||||
KINGSLAND, Frank Leonard | Administrateur | 8 Holsart Close KT20 5EJ Tadworth Surrey | England | British | Director Reseller Operations | 67457890002 | ||||
MAY, Gavin Disney | Administrateur | North Park Newcastle Upon Tyne NE13 9AA Tyne & Wear | England | British | Director | 85874690001 | ||||
MCFARLAND, Adrienne Ann | Administrateur | North Park Newcastle Upon Tyne NE13 9AA Tyne & Wear | United Kingdom | British | Human Resources Director | 125854290002 | ||||
MITCHELL, Alastair John | Administrateur | North Park Newcastle Upon Tyne NE13 9AA Tyne & Wear | United Kingdom | British | Finance Director | 79762180002 | ||||
RAY, Josephine | Administrateur | 14 Elmfield Gardens Gosforth NE3 4XB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 117640490002 | ||||
SARAGOSSI, Mark | Administrateur | 3 Hurst Place HA6 2JS Northwood Middlesex | England | British | Company Director | 36140510002 | ||||
SCHOFIELD, Alan Donald | Administrateur | 1 Summerhill Avenue NE3 5QJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Finance Director | 115685980001 | ||||
SHERMAN, Steven Jay | Administrateur | 31 Chapel Square GU25 4SZ Virginia Water Surrey | British | Vp Development | 55547640001 | |||||
STEINGOLD, Lawrence Gerald | Administrateur | Flat 33 20 Lawn Lane Vauxhall SW8 1GA London | England | British | Accountant | 96504890001 | ||||
THOMSON, Neil, Doctor | Administrateur | Lochletter House Balnain IV63 6XW Drumnadrochit Inverness | United Kingdom | British | Development Director | 29859190002 | ||||
WHEATON, Paul James Michael | Administrateur | 6 Symondson Mews RG12 5TE Binfield Berkshire | British | Sales Director | 7575390002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetra Limited | 06 avr. 2016 | North Park NE13 9AA Newcastle Upon Tyne Tetra Limited United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture | Créé le 04 juin 1990 Livré le 16 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company and/or rapidideo limited now k/a tetra holdings limited to the chargee under or pursuant to this debenture and/or the loan agreement and/or the guarantee as defined. | |
Brèves mentions (See form 395-ref M776C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of charge | Créé le 25 mai 1990 Livré le 11 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies now or hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 22 juin 1989 Livré le 27 juin 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 avr. 1988 Livré le 21 avr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All bank debts both present and future, benefit of all rights relating thereof, debts and claim, copyrights patents, trademarks, inventions, design, know how and other intellectual property rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 02 mars 1987 Livré le 12 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any monies now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC. And all interest now due or henceforth to become due in respect thereof. The schedule the accounts at lloyds bank PLC designated "lloyds bank PLC re tetra business systems LTD business call a/c; lloyds bank PLC re tetra business systems LTD extra interest a/c; lloyds bank PLC re tetra business systems LTD fixed term deposit". | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SAGE ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0