ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED

ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01447845
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ILLINGWORTH (HEALTH FOOD) AGENCIES LIMITED11 sept. 197911 sept. 1979

    Quels sont les derniers comptes de ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Jennifer Anne Brierley en tant que secrétaire le 25 juil. 2012

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share cap increased from £100000 to £255859 27/03/2012
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    État du capital après une attribution d'actions au 25 nov. 2011

    • Capital: GBP 255,859.00
    4 pagesSH01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr William Shepherd en tant qu'administrateur le 01 août 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Smerdon en tant que directeur le 01 août 2011

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Jennifer Anne Brierley le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    3 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritishSolicitor162873980001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishChartered Accountant120451550002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Secrétaire
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    BritishDirector/Company Secretary20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secrétaire
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secrétaire
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    PARKER, Charles Peter
    65 Church Avenue
    LS6 4JX Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    65 Church Avenue
    LS6 4JX Leeds
    West Yorkshire
    British11421620001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Secrétaire
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secrétaire
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    BritishDirector/Company Secretary20341960001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director118296490001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Administrateur
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    BritishFinance Director39644740002
    ILLINGWORTH, Barry Gaythorne
    Westleigh Hebdenbridge Road
    Oxenhope
    BD22 9JS Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Westleigh Hebdenbridge Road
    Oxenhope
    BD22 9JS Keighley
    West Yorkshire
    BritishManager12352410001
    ILLINGWORTH, Janet Christine
    Westleigh Hebdenbridge Road
    Oxenhope
    BD22 9JS Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Westleigh Hebdenbridge Road
    Oxenhope
    BD22 9JS Keighley
    West Yorkshire
    BritishManager12544240001
    ILLINGWORTH, Leslie
    Smithy House Barn
    Leeming Oxenhope
    BD22 9NP Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Smithy House Barn
    Leeming Oxenhope
    BD22 9NP Keighley
    West Yorkshire
    BritishManager11421650001
    ILLINGWORTH, Leslie Gaythorne
    650 Thornton Road
    Thornton
    BD13 3PZ Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    650 Thornton Road
    Thornton
    BD13 3PZ Bradford
    West Yorkshire
    BritishManager12352400001
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Administrateur
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector8991780003
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    BritishChairman Pharmacist2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    BritishChief Executive35546210001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Administrateur
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissDirector43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GermanyChief Finance Officer62107000001
    PARKER, Charles Peter
    65 Church Avenue
    LS6 4JX Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    65 Church Avenue
    LS6 4JX Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant11421620001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishCompany Secretary16898700002
    SMITH, Ian Elliot
    72 Padleys Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    72 Padleys Lane
    Burton Joyce
    NG14 5BW Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishSales & Marketing41145560001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    BritishCommercial Director51796560002
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant122881190001
    WARD, Michael Ashley
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Administrateur
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    EnglandBritishGroup Finance Director114711020001

    ILLINGWORTH HEALTH FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 août 1986
    Livré le 12 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 23 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 mars 1984
    Livré le 02 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M15). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 02 avr. 1982
    Livré le 22 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future inc. Goodwill & book debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank LTD
    Transactions
    • 22 avr. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0