SUNDERNOTE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUNDERNOTE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01448096
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUNDERNOTE LIMITED ?

    • fabrication de vêtements de travail (14120) / Industries manufacturières

    Où se situe SUNDERNOTE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SUNDERNOTE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SUNDERNOTE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 nov. 2013

    20 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 14 nov. 2013

    20 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 oct. 2013

    20 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 avr. 2013

    20 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 14 nov. 2012

    17 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    40 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de Whittington Hall Whittington Road Whittington Worcester Worcestershire WR5 2ZX le 30 mai 2012

    3 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Richard Mark Blundell en tant que directeur le 24 avr. 2012

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    20 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 avr. 2012

    État du capital au 26 avr. 2012

    • Capital: GBP 90,168
    SH01

    Nomination de Paul Haden en tant qu'administrateur le 14 nov. 2011

    3 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    6 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG01

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital après une attribution d'actions au 23 mai 2011

    • Capital: GBP 90,258
    6 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    22 pagesAR01

    legacy

    5 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de SUNDERNOTE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THE WHITTINGTON PARTNERSHIP LLP
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    78210930001
    CATTO, Ralph Fergus
    Queens Road
    GL50 2LR Cheltenham
    19
    Gloucestershire
    Administrateur
    Queens Road
    GL50 2LR Cheltenham
    19
    Gloucestershire
    EnglandBritishCeo87065920001
    GARNETT, Alan
    43 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    43 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Coventry
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director14137920001
    HADEN, Paul Court
    St Andrews Road
    KY9 1HZ Largoward
    6
    Fife
    Administrateur
    St Andrews Road
    KY9 1HZ Largoward
    6
    Fife
    United KingdomBritishDirector166228430001
    RIGHTON, Robert Andrew
    Oldhams Barn
    Throckmorton Road Wyre
    WR10 2PW Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Oldhams Barn
    Throckmorton Road Wyre
    WR10 2PW Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishAccountant51595850003
    CLIFF, Richard Martyn
    195 High Street
    B64 5HW Cradley Heath
    West Midlands
    Secrétaire
    195 High Street
    B64 5HW Cradley Heath
    West Midlands
    British61911280001
    HAMMOND, Coralie Francis
    Rose Cottage
    Fentham Road Hampton In Arden
    B92 0AY Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    Rose Cottage
    Fentham Road Hampton In Arden
    B92 0AY Solihull
    West Midlands
    British24752470003
    WALKER, Regaina
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    British92468480001
    WALKER, Regaina
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    British92468480001
    BANNER-SMITH, Jeanette
    26 Shugborough Way Chase Meadow
    Hayes Heath
    WS11 2YT Staffordshire
    West Midlands
    Administrateur
    26 Shugborough Way Chase Meadow
    Hayes Heath
    WS11 2YT Staffordshire
    West Midlands
    BritishSales Manager123345190001
    BLUNDELL, Richard Mark
    West End
    GL54 3EZ Northleach
    The Old Forge
    Gloucestershire
    Administrateur
    West End
    GL54 3EZ Northleach
    The Old Forge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector155845400001
    CARTHEW, John Michael
    Four Ashes Road
    Bentley Heath
    B93 8LX Solihull
    Bourton Spinney 12
    West Midlands
    Administrateur
    Four Ashes Road
    Bentley Heath
    B93 8LX Solihull
    Bourton Spinney 12
    West Midlands
    EnglandBritishManaging Director88145000002
    HAMMOND, Colin Jeffrey
    14 Ashbury Court
    Henley In Arden
    B95 5AF Solihull
    Administrateur
    14 Ashbury Court
    Henley In Arden
    B95 5AF Solihull
    BritishCompany Director58263440002
    HAMMOND, Coralie Francis
    Rose Cottage
    Fentham Road Hampton In Arden
    B92 0AY Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Rose Cottage
    Fentham Road Hampton In Arden
    B92 0AY Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director24752470003
    KLUK, Steven
    11 Maurice Walk
    NW11 6JX London
    Administrateur
    11 Maurice Walk
    NW11 6JX London
    EnglandBritishCompany Director74189880002
    POWELL, Maxene Sheila
    4 Nuthurst Grove Dorridge
    Bentley Heath
    B93 8PD Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    4 Nuthurst Grove Dorridge
    Bentley Heath
    B93 8PD Solihull
    West Midlands
    BritishPersonal Assistant45149580001
    WALKER, Regaina
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    BritishFinancial/Office Manager92468480001
    WALKER, Regaina
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    52 Acheson Road
    Hall Green
    B28 0TS Birmingham
    West Midlands
    BritishBook Keeper92468480001

    SUNDERNOTE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    All assets debenture
    Créé le 13 sept. 2011
    Livré le 17 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 17 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    General memorandum of pledge and hypothecation of goods
    Créé le 13 sept. 2011
    Livré le 16 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pledge upon all negotiable instruments andall goods or the documents of title and all policies or certificates of insurance relating to goods see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 13 sept. 2011
    Livré le 16 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 13 sept. 2011
    Livré le 16 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guiding Capital Limited
    Transactions
    • 16 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 18 mars 2011
    Livré le 26 mars 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The account and the deposit balance. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Segro (Knbc) Limited
    Transactions
    • 26 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2010
    Livré le 07 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham City Council
    Transactions
    • 07 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    All assets debenture
    Créé le 10 déc. 2009
    Livré le 24 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 déc. 2009
    Livré le 04 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Invoice finance agreement
    Créé le 23 déc. 2008
    Livré le 27 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All book and other debts revenues and claims present and future and all things in action owing to or owned by the company, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 27 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2008
    Livré le 27 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 27 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2008
    Livré le 15 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 11 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 11 nov. 2005
    Livré le 15 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 15 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 sept. 2004
    Livré le 05 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 24 juil. 2003
    Livré le 05 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill specified and other debts uncalled capital bixtures fittings fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cattles Invoice Finance (Oxford) Limited
    Transactions
    • 05 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 1998
    Livré le 02 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement
    Brèves mentions
    The l/h premises at 90A bordesley street,digbeth,birmingham together with all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery of the company from time to time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Maryvonne Cossard Barron
    • William John Barron
    Transactions
    • 02 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 31 oct. 1995
    Livré le 06 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 25 juil. 1983
    Livré le 27 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All bookdebts and other debts present and future.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 1980
    Livré le 23 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUNDERNOTE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 mai 2012Administration started
    14 nov. 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Masters
    Leonard Curtis Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    practitioner
    Leonard Curtis Bamfords Trust House
    85-89 Colmore Row
    B3 2BB Birmingham
    Andrew Poxon
    Dte Leonard Curtis
    Bamfords Trust House
    B3 2BB 85-89 Colmore Row
    Birmingham
    practitioner
    Dte Leonard Curtis
    Bamfords Trust House
    B3 2BB 85-89 Colmore Row
    Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0