CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED

CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01448409
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    • Agences de publicité (73110) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Mazars Llp, 30
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCORE OUTDOOR (MIDLANDS) LIMITED06 sept. 199906 sept. 1999
    VISION POSTERS LIMITED13 sept. 197913 sept. 1979

    Quels sont les derniers comptes de CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 sept. 2022

    11 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD à C/O Mazars Llp, 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 11 mai 2022

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 33 Golden Square London W1F 9JT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 33 Golden Square London W1F 9JT à Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD le 05 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2021

    LRESSP

    Notification de Clear Channel Overseas Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mars 2021

    2 pagesPSC02

    Cessation de Clear Channel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mars 2021

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 22 déc. 2020

    • Capital: GBP 1.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account of the company of £20,000 be cancelled in it's entirety. 15/12/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Byron Kee Chye Hoo en tant que directeur le 04 mai 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Adam Paul Raymond Tow en tant qu'administrateur le 04 mai 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Clear Channel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 févr. 2018

    2 pagesPSC02

    Qui sont les dirigeants de CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COCHRANE, Justin Malcolm Brian
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    EnglandEnglish110390650002
    TOW, Adam Paul Raymond
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp, 30
    EnglandBritish66766420004
    ANDREWS, Nick
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Secrétaire
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    British109746840001
    BEW, Gerard Francis
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    Secrétaire
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    British11996520001
    EMBREY, Jacqueline Gaylor
    18 Crown Lane
    Four Oaks
    B74 4SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    18 Crown Lane
    Four Oaks
    B74 4SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British46477960001
    EMENY, Selina Holliday
    16 Priory Road
    Kew
    TW9 3DF Richmond
    Surrey
    Secrétaire
    16 Priory Road
    Kew
    TW9 3DF Richmond
    Surrey
    British76404320002
    TERRY, Philip
    2 Bluebird Close
    WS14 9YL Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    2 Bluebird Close
    WS14 9YL Lichfield
    Staffordshire
    British76924060001
    ANDREWS, Nicholas James
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish168572900001
    ATKINSON, Robert Nigel
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish128922360001
    BEVAN, Jonathan David
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    Administrateur
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    United KingdomBritish110358490001
    BEW, Gerard Francis
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    Administrateur
    Park House Tong
    Near Shifnal
    TF11 8PW Shifnal
    Shropshire
    EnglandBritish11996520001
    BOWMAN, John Reid
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    Administrateur
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritish79292840001
    FINDLAY, Richard
    Woodville 20 Laverockbank Road
    EH5 3DE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Woodville 20 Laverockbank Road
    EH5 3DE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish35695630001
    FRANCE, Julie
    10 Park Avenue
    SW14 8AT London
    Administrateur
    10 Park Avenue
    SW14 8AT London
    EnglandBritish110526070001
    GEORGE, Stephen Terence
    5 Wood Lane
    Streetly
    B74 3LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    5 Wood Lane
    Streetly
    B74 3LP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British24649850001
    HOO, Byron Kee Chye
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    EnglandBritish214640470001
    O'HARA, Henry John
    9 Croftdown Road
    B17 8RA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    9 Croftdown Road
    B17 8RA Birmingham
    West Midlands
    British11996550003
    OLIVER, David Henry Maxwell
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT
    United KingdomBritish67052550001
    SPRING, Stephanie
    Courtnell Street
    W2 5BX London
    34
    Administrateur
    Courtnell Street
    W2 5BX London
    34
    EnglandBritish102849950001
    WILSON, Alan Raeburn
    11 Inchcolm Terrace
    EH30 9NA South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    11 Inchcolm Terrace
    EH30 9NA South Queensferry
    West Lothian
    British33799400001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Clear Channel Overseas Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    03 mars 2021
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Uk
    Numéro d'enregistrement01441672
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Clear Channel Uk Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    12 févr. 2018
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement950526
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Clear Channel Central Limited
    Deerdykes View
    Cumbernauld
    G68 9HN Glasgow
    119
    Scotland
    31 janv. 2017
    Deerdykes View
    Cumbernauld
    G68 9HN Glasgow
    119
    Scotland
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScottish Law
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrementSc198208
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 15 mars 1994
    Livré le 23 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 61 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM394463 and proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 mars 1994
    Livré le 23 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 60 charlotte street,birmingham,west midlands t/n WM379419 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 15 mars 1994
    Livré le 23 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 3/4/5 water court,36 water street,birmingham west midlands t/n WM473698 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 déc. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 02 juil. 1993
    Livré le 16 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 1992
    Livré le 11 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1991
    Livré le 13 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    61 charlotte street birmingham west midlands.
    Personnes ayant droit
    • T S B Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1991
    Livré le 13 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 3, 4 and 5 lansdowne house, (otherwise known as water court) water street, birmingham, west midlands.
    Personnes ayant droit
    • T S B Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1991
    Livré le 13 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    60 charlotte street birmingham west midlands.
    Personnes ayant droit
    • T S B Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 juil. 1990
    Livré le 11 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • T S B Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 mars 1990
    Livré le 08 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property 60 and 61 charlotte street, birmingham west midlands t/ns wm 379419 and wm 394463 together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 19 juil. 1989
    Livré le 01 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H units 3, 4 & 5 lansdowne house, water street birmingham W. midlands & goods & goodwill (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1986
    Livré le 25 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £80,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    F/H three stoney office premises known as 61 charlotte street, birmingham west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Norwich General Trust Limited
    Transactions
    • 25 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 1986
    Livré le 06 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property being part of 57/61 charlotte street, birmingham.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 14 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 06 juin 1985
    Livré le 12 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks, shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 14 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CLEAR CHANNEL (MIDLANDS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2021Commencement of winding up
    12 mars 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0