PRIMETIME NO. 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRIMETIME NO. 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01448776
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    • Activités de distribution de programmes de télévision (59133) / Information et communication

    Où se situe PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Shepherds Building Central
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OXFORD SCIENTIFIC FILMS LIMITED29 nov. 200429 nov. 2004
    SOUTHERN TELEVISION LIMITED26 févr. 198226 févr. 1982
    SOUTHERN PICTURES LIMITED14 sept. 197914 sept. 1979

    Quels sont les derniers comptes de PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 01 sept. 2022

    • Capital: GBP 0.10
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Cessation de la nomination de Marie Lucile Schweitzer en tant que directeur le 05 août 2022

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Shepherds Building Central Legal Department, Endemol Shine Uk Charecroft Way London W14 0EE United Kingdom à Shepherds Building Central Charecroft Way London W14 0EE le 03 août 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    5 pagesAA

    Nomination de Ms Marie Schweitzer en tant qu'administrateur le 03 août 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Anthony John Richards en tant qu'administrateur le 03 août 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Catherine Patricia Payne en tant qu'administrateur le 03 août 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Wim Theo Gaby Ponnet en tant que directeur le 03 août 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Terry William Downing en tant que directeur le 03 août 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Terry William Downing en tant qu'administrateur le 09 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony John Richards en tant que directeur le 09 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Catherine Patricia Payne en tant que directeur le 25 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Wim Theo Gaby Ponnet en tant qu'administrateur le 20 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KEPPLER, Bronagh Elizabeth Ann
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Secrétaire
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    172334810001
    PAYNE, Catherine Patricia
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Administrateur
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    EnglandAustralianDirector205324840001
    RICHARDS, Anthony John
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Administrateur
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector269661310001
    BARRON, Maureen Patricia
    277 Edgecliff Road
    Woollahra
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2025
    Australia
    Secrétaire
    277 Edgecliff Road
    Woollahra
    FOREIGN Sydney
    New South Wales 2025
    Australia
    AustralianGeneral Manager71849590001
    IRLAM, Felicity Mary
    2 Suffolk Villas
    Longfield Street
    SW18 5RG London
    Secrétaire
    2 Suffolk Villas
    Longfield Street
    SW18 5RG London
    British42627330001
    MEACOCK, Catherine Anne
    6b Somerset Road
    Ealing
    W13 9PB London
    Secrétaire
    6b Somerset Road
    Ealing
    W13 9PB London
    British46175710002
    TATE, Maxine
    35a Walterton Road
    W9 3PE London
    Secrétaire
    35a Walterton Road
    W9 3PE London
    BritishAccountant60430270003
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    United Kingdom
    38636470004
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    22 Melton Street
    Euston Square
    NW1 2BW London
    Secrétaire désigné
    22 Melton Street
    Euston Square
    NW1 2BW London
    900007560001
    BALNAVES, Neil Richard
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Administrateur
    1 Milton Avenue
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    AustralianCompany Director53758580001
    BIRKS, Clare
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    Administrateur
    15 Saint Michaels Road
    SW9 0SN London
    United KingdomBritishChief Executive60648500001
    CLARK, Peter Antony
    108 Roseneath Road
    SW11 6AQ London
    Administrateur
    108 Roseneath Road
    SW11 6AQ London
    United KingdomBritishCompany Director60713200001
    DOWNING, Terry William
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Administrateur
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    United KingdomBritishConsultant Managment109287950001
    IRVINE, Ian Alexander Noble
    14 Tregunter Road
    SW10 9LR London
    Administrateur
    14 Tregunter Road
    SW10 9LR London
    BritishDirector53758680001
    LEWORTHY, Judy
    43 Hammersmith Grove
    W6 0NE London
    Administrateur
    43 Hammersmith Grove
    W6 0NE London
    BritishCompany Director66895130001
    LEWORTHY, Richard
    43 Hammersmith Grove
    W6 ONE London
    Administrateur
    43 Hammersmith Grove
    W6 ONE London
    BritishCompany Director95593600001
    LYONS, Frank
    48 Dymock Street
    SW6 3HA London
    Administrateur
    48 Dymock Street
    SW6 3HA London
    IrishAca71588050002
    PAYNE, Catherine Patricia
    Peninsula Heights
    93 Albert Embankment
    SE1 7TY London
    34
    United Kingdom
    Administrateur
    Peninsula Heights
    93 Albert Embankment
    SE1 7TY London
    34
    United Kingdom
    United KingdomAustralianChief Executive Television Sales69630880003
    PONNET, Wim Theo Gaby
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Administrateur
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    FranceBelgianDirector210379090001
    PRICE, Richard Shirvell
    Beech Knoll House
    Aldbourne
    SN8 2EJ Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Beech Knoll House
    Aldbourne
    SN8 2EJ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director13640490003
    RICHARDS, Anthony John
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Administrateur
    Legal Department, Endemol Shine Uk
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector138456730002
    SAY, David Giles Ashworth
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Administrateur
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    AustralianCompany Director53758640001
    SAY, David Giles Ashworth
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Administrateur
    33 Lynbara Avenue
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    AustralianCompany Director53758640001
    SCHWEITZER, Marie Lucile
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    Administrateur
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    United Kingdom
    FranceFrenchDirector272749510001
    WILSON, Nigel Peter
    158 Broomwood Road
    SW11 6JY London
    Administrateur
    158 Broomwood Road
    SW11 6JY London
    BritishFinance Director77540330001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PRIMETIME NO. 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Primetime Limited
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    England
    30 juin 2016
    Charecroft Way
    W14 0EE London
    Shepherds Building Central
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 1948 To 1981
    Lieu d'enregistrementCompanies Register England And Wales
    Numéro d'enregistrement901456
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    PRIMETIME NO. 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2000
    Livré le 17 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land the real property tangible movable property all the tangible movable property accounts with the bank all rights and claims to which the company at the date of creation of the charge or may thereafter become entitled in relation to all moneys at the date of creation of the charge or at any time thereafter standing to the credit of any bank accounts opened or maintained with the bank together with all rights relating or attaching thereto (including the right to interest) intellectual property the intellectual property goodwill all goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Westpac Banking Corporation
    Transactions
    • 17 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 août 1999
    Livré le 12 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 25 mai 1994
    Livré le 03 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Co.
    Transactions
    • 03 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 25 mai 1994
    Livré le 27 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreements and/or any other agreement (as defined in the deed)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co.Limited
    Transactions
    • 27 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 09 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 14 févr. 1994
    Livré le 28 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "principal agreement" dated 14TH february 1994 and this deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co.Limited
    Transactions
    • 28 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 1989
    Livré le 12 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 12 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0