EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED

EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01450193
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?

    • usinage (25620) / Industries manufacturières

    Où se situe EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O
    KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED
    1 City Road East
    M15 4PN Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2016

    14 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Griffin Court Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancs M3 5EQ à C/O C/O 1 City Road East Manchester M15 4PN le 15 juin 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2015

    13 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Changement d'adresse du siège social de Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester M3 5EQ à Griffin Court Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancs M3 5EQ le 11 nov. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    11 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 30 oct. 2014

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de Lipton Close St Johns Road Bootle Liverpool Merseyside L20 8PU à Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester M3 5EQ le 27 oct. 2014

    2 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2014

    État du capital au 11 juil. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * Lipton Close St Johns Road Bootle Liverpool L20 8PU United Kingdom* le 27 janv. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Hassall le 01 juin 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Ian Richard Holder Slaughter le 01 déc. 2010

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Paul Hassall le 01 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Lipton Close St Johns Road Brasenose Industrial Estate Bootle Merseyside L20 8PU* le 25 janv. 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SLAUGHTER, Ian Richard Holder
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    British39851430003
    HASSALL, Michael
    Warwick Road
    Hale
    WA15 9NS Altrincham
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick Road
    Hale
    WA15 9NS Altrincham
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish48866820004
    HASSALL, Stephen Paul
    Brow
    7 Victoria Way
    L37 1YF Formby
    Berry
    Merseyside
    United Kingdom
    Administrateur
    Brow
    7 Victoria Way
    L37 1YF Formby
    Berry
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish7207310010
    SLAUGHTER, Ian Richard Holder
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Matham Road
    East Molesey
    KT8 0SX Surrey
    25
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish39851430003
    CHISNELL, Paul Rowland Robert Kenneth
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    British47197920001
    HASSALL, Edward William
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    British7207300001
    HASSALL, Gillian
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    Secrétaire
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    British32812860003
    CHISNELL, Paul Rowland Robert Kenneth
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    The Poplars
    20 Stonyhurst Crescent Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish47197920001
    HASSALL, Edward William
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    3 Alton Close
    Hightown
    L38 9GE Liverpool
    Merseyside
    British7207300001
    HASSALL, Gillian
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    Administrateur
    Abbotsmead
    3 St Lukes Church Road
    Formby
    Merseyside
    British32812860003
    HASSALL, Michael
    1 Hornbeam Drive
    CW8 2GA Hartford
    Cheshire
    Administrateur
    1 Hornbeam Drive
    CW8 2GA Hartford
    Cheshire
    British48866820001

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 27 sept. 2002
    Livré le 04 oct. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 04 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 07 avr. 2000
    Livré le 13 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee by the company whether pursuant to a loan agreement dated 24TH march 2000 or the guarantee & debenture or otherwise
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Industrial Mezzanine Fund L.P.
    Transactions
    • 13 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 1997
    Livré le 08 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Edwards Engineering (L'pool) LTD. Pension Plan
    Transactions
    • 08 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 1992
    Livré le 28 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • S.P.Hassall
    Transactions
    • 28 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 oct. 1988
    Livré le 12 oct. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 12 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 16 janv. 1981
    Livré le 22 janv. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1981Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 11 juin 1980
    Livré le 23 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1980Enregistrement d'une charge

    EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 oct. 2014Commencement of winding up
    02 avr. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan David Fallows
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester
    practitioner
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0