EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01450193 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o C/O KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED 1 City Road East M15 4PN Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 16 pages | LIQ14 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2016 | 14 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Griffin Court Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancs M3 5EQ à C/O C/O 1 City Road East Manchester M15 4PN le 15 juin 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2015 | 13 pages | 4.68 | ||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 3 pages | F10.2 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester M3 5EQ à Griffin Court Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancs M3 5EQ le 11 nov. 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 11 pages | 4.20 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lipton Close St Johns Road Bootle Liverpool Merseyside L20 8PU à Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester M3 5EQ le 27 oct. 2014 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Lipton Close St Johns Road Bootle Liverpool L20 8PU United Kingdom* le 27 janv. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Hassall le 01 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Ian Richard Holder Slaughter le 01 déc. 2010 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Paul Hassall le 01 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Lipton Close St Johns Road Brasenose Industrial Estate Bootle Merseyside L20 8PU* le 25 janv. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAUGHTER, Ian Richard Holder | Secrétaire | Matham Road East Molesey KT8 0SX Surrey 25 Kent United Kingdom | British | 39851430003 | ||||||
| HASSALL, Michael | Administrateur | Warwick Road Hale WA15 9NS Altrincham 2 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 48866820004 | |||||
| HASSALL, Stephen Paul | Administrateur | Brow 7 Victoria Way L37 1YF Formby Berry Merseyside United Kingdom | United Kingdom | British | 7207310010 | |||||
| SLAUGHTER, Ian Richard Holder | Administrateur | Matham Road East Molesey KT8 0SX Surrey 25 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 39851430003 | |||||
| CHISNELL, Paul Rowland Robert Kenneth | Secrétaire | The Poplars 20 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DS Warrington Cheshire | British | 47197920001 | ||||||
| HASSALL, Edward William | Secrétaire | 3 Alton Close Hightown L38 9GE Liverpool Merseyside | British | 7207300001 | ||||||
| HASSALL, Gillian | Secrétaire | Abbotsmead 3 St Lukes Church Road Formby Merseyside | British | 32812860003 | ||||||
| CHISNELL, Paul Rowland Robert Kenneth | Administrateur | The Poplars 20 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DS Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 47197920001 | |||||
| HASSALL, Edward William | Administrateur | 3 Alton Close Hightown L38 9GE Liverpool Merseyside | British | 7207300001 | ||||||
| HASSALL, Gillian | Administrateur | Abbotsmead 3 St Lukes Church Road Formby Merseyside | British | 32812860003 | ||||||
| HASSALL, Michael | Administrateur | 1 Hornbeam Drive CW8 2GA Hartford Cheshire | British | 48866820001 |
EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Créé le 27 sept. 2002 Livré le 04 oct. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 07 avr. 2000 Livré le 13 avr. 2000 | En cours | Montant garanti All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee by the company whether pursuant to a loan agreement dated 24TH march 2000 or the guarantee & debenture or otherwise | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 sept. 1997 Livré le 08 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 oct. 1992 Livré le 28 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £20,000 | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 03 oct. 1988 Livré le 12 oct. 1988 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 16 janv. 1981 Livré le 22 janv. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book debts and other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 11 juin 1980 Livré le 23 juin 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
EDWARDS ENGINEERING (LIVERPOOL) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0