CHIEFTAIN GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHIEFTAIN GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01455149
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières
    • Autres installations en construction (43290) / Construction
    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O REDHALL GROUP PLC
    Unit 3 Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHIEFTAIN GROUP P.L.C.11 août 198711 août 1987
    CHIEFTAIN INSULATION LIMITED18 oct. 197918 oct. 1979

    Quels sont les derniers comptes de CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2018 au 31 mars 2019

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 014551490013, créée le 24 janv. 2019

    46 pagesMR01

    Inscription de la charge 014551490012, créée le 24 janv. 2019

    45 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell David Haworth le 10 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Wayne Pearson en tant que directeur le 03 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Russell David Haworth en tant qu'administrateur le 03 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Philip Comer le 09 août 2018

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que secrétaire le 01 juil. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant que secrétaire le 02 juil. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que directeur le 29 juin 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant qu'administrateur le 02 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Philip Brierley en tant que directeur le 31 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Wayne Pearson en tant qu'administrateur le 19 mars 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    8 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN à C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA le 05 août 2016

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 avr. 2016

    État du capital au 29 avr. 2016

    • Capital: GBP 450,925
    SH01

    Qui sont les dirigeants de CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    248241940001
    COMER, Simon Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish206088760003
    HAWORTH, Russell David
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish201533400002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187596050001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Secrétaire
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    British134974090001
    ADAMS, Laurence George
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    Administrateur
    15 Rolley Way
    Castlefields
    NE42 5FH Prudhoe
    Northumberland
    EnglandBritish87979230002
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish54808010002
    CORBISHLEY, Michael
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    Administrateur
    Overidge Farm Beckside
    Cartmel
    LA11 7SP Grange-Over-Sands
    Cumbria
    EnglandBritish101553180002
    COULSON, William Andrew
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    40 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish36723860001
    CUTCHIE, Anthony William
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    68 Davison Avenue
    NE26 3SU Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish45955990001
    DAWSON, John Frederic
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Dale
    LS29 6LW Menston
    1
    West Yorkshire
    British8366360002
    ELLIOTT, Stanley, Fcma
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    12 Killiebrigs
    Heddon On The Wall
    NE15 0DD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British7203790001
    FLEETWOOD, Christopher John
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    4 The Meadows
    DL10 7DU Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish1718030001
    FOSTER, Robert Simon
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    Administrateur
    Aish
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford
    Devon
    EnglandBritish134973970001
    GOODENOUGH, Anthony
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    Administrateur
    Bakery Drive
    Grange Park
    TS19 0SN Stockton-On-Tees
    1
    Cleveland
    EnglandBritish139196050001
    IREDALE, George Henry Cecil
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    Redmays
    14 North Lodge Lambton Park
    DH3 4AZ Chester Le Street
    County Durham
    British141871680001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JESTER, Tony
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    Administrateur
    6 Cranbourne Drive
    TS10 2SP Redcar
    Cleveland
    EnglandBritish107694130001
    JOHNSON, Raymond
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    Administrateur
    1 Colville Court
    DH9 6UW East Stanley
    County Durham
    EnglandBritish266049760001
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish188444350001
    LEWIS-JONES, Christopher
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    Administrateur
    Monks Lane
    Acton
    CW5 8LE Nantwich
    The Smithy
    Cheshire
    EnglandBritish134974090001
    MARTINDALE, Stephen Richard
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    Administrateur
    Am Waldeck 14
    FOREIGN 34537 Bad Wildungen
    Germany
    GermanyBritish77194110002
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    Administrateur
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    United KingdomIrish106172200001
    OLIVER, Malcolm William
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    Administrateur
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    EnglandBritish143300760001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish212154420001
    PENDLETON, Alan George
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    12 Harrop Road
    Hale
    WA15 9BX Altrincham
    Cheshire
    British30248370001
    PRICE, Anthony Hall
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    Administrateur
    Irton
    CA19 1UZ Holmrook
    Mecklin
    Cumbria
    EnglandBritish134973860001
    SHIPPEN, Kenneth
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    14 Rectory Park
    NE61 2SZ Morpeth
    Northumberland
    British67917400001
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Red Hall Court
    WF1 2UN Wakefield
    1
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish58727820002
    TAYLOR, William Platt
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    Administrateur
    Ryton House
    Mainsforth
    DL17 9AA Ferryhill
    County Durham
    British7203810001
    WARDLE, Peter
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    14 Brandling Park
    Jesmond
    NE2 4RR Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish73518260002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 avr. 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement263995
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CHIEFTAIN GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 janv. 2019
    Livré le 29 janv. 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Downing LLP (As Security Trustee)
    Transactions
    • 29 janv. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 janv. 2019
    Livré le 29 janv. 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • (1) 1798 Volantis Fund Limited and (2) 1798 Volantis Catalyst Fund Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2015
    Livré le 02 janv. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alphagen Volantis Catalyst Fund Limited
    • Alphagen Volantis Fund Limited
    Transactions
    • 02 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 21 janv. 2011
    Livré le 28 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2009
    Livré le 09 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 mai 2004
    Livré le 17 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 09 sept. 1996
    Livré le 12 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 août 1996
    Livré le 13 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 02 nov. 1994
    Livré le 11 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 26 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 janv. 1988
    Livré le 05 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juin 1985
    Livré le 11 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juin 1985Enregistrement d'une charge
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 sept. 1984
    Livré le 28 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 20 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0