CHIEFTAIN GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CHIEFTAIN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01455149 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o C/O REDHALL GROUP PLC Unit 3 Calder Close WF4 3BA Wakefield West Yorkshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2018 au 31 mars 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge 014551490013, créée le 24 janv. 2019 | 46 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 014551490012, créée le 24 janv. 2019 | 45 pages | MR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Russell David Haworth le 10 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wayne Pearson en tant que directeur le 03 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Russell David Haworth en tant qu'administrateur le 03 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Philip Comer le 09 août 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que secrétaire le 01 juil. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant que secrétaire le 02 juil. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John Kelly en tant que directeur le 29 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Philip Comer en tant qu'administrateur le 02 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Brierley en tant que directeur le 31 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Wayne Pearson en tant qu'administrateur le 19 mars 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Redhall Group Plc 1 Red Hall Court Wakefield West Yorkshire WF1 2UN à C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA le 05 août 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMER, Simon Philip | Secrétaire | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 248241940001 | |||||||
| COMER, Simon Philip | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | United Kingdom | British | 206088760003 | |||||
| HAWORTH, Russell David | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 201533400002 | |||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Secrétaire | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| KELLY, Christopher John | Secrétaire | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | 187596050001 | |||||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Secrétaire | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | British | 134974090001 | ||||||
| ADAMS, Laurence George | Administrateur | 15 Rolley Way Castlefields NE42 5FH Prudhoe Northumberland | England | British | 87979230002 | |||||
| BRIERLEY, Philip | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 54808010002 | |||||
| CORBISHLEY, Michael | Administrateur | Overidge Farm Beckside Cartmel LA11 7SP Grange-Over-Sands Cumbria | England | British | 101553180002 | |||||
| COULSON, William Andrew | Administrateur | 40 Holly Avenue Jesmond NE2 2PY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36723860001 | |||||
| CUTCHIE, Anthony William | Administrateur | 68 Davison Avenue NE26 3SU Whitley Bay Tyne & Wear | United Kingdom | British | 45955990001 | |||||
| DAWSON, John Frederic | Administrateur | Park Dale LS29 6LW Menston 1 West Yorkshire | British | 8366360002 | ||||||
| ELLIOTT, Stanley, Fcma | Administrateur | 12 Killiebrigs Heddon On The Wall NE15 0DD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 7203790001 | ||||||
| FLEETWOOD, Christopher John | Administrateur | 4 The Meadows DL10 7DU Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 1718030001 | |||||
| FOSTER, Robert Simon | Administrateur | Aish TQ10 9JG South Brent Stamford Devon | England | British | 134973970001 | |||||
| GOODENOUGH, Anthony | Administrateur | Bakery Drive Grange Park TS19 0SN Stockton-On-Tees 1 Cleveland | England | British | 139196050001 | |||||
| IREDALE, George Henry Cecil | Administrateur | Redmays 14 North Lodge Lambton Park DH3 4AZ Chester Le Street County Durham | British | 141871680001 | ||||||
| JACKSON, David James | Administrateur | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 62867720010 | |||||
| JESTER, Tony | Administrateur | 6 Cranbourne Drive TS10 2SP Redcar Cleveland | England | British | 107694130001 | |||||
| JOHNSON, Raymond | Administrateur | 1 Colville Court DH9 6UW East Stanley County Durham | England | British | 266049760001 | |||||
| KELLY, Christopher John | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 188444350001 | |||||
| LEWIS-JONES, Christopher | Administrateur | Monks Lane Acton CW5 8LE Nantwich The Smithy Cheshire | England | British | 134974090001 | |||||
| MARTINDALE, Stephen Richard | Administrateur | Am Waldeck 14 FOREIGN 34537 Bad Wildungen Germany | Germany | British | 77194110002 | |||||
| O'KANE, John Peter | Administrateur | Station Lane Burton Leonard HG3 3RU Harrogate Holly Cottage North Yorkshire | United Kingdom | Irish | 106172200001 | |||||
| OLIVER, Malcolm William | Administrateur | 12c Burtree Lane DL3 0XQ Darlington County Durham | England | British | 143300760001 | |||||
| PEARSON, Wayne | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Calder Close WF4 3BA Wakefield Unit 3 West Yorkshire England | England | British | 212154420001 | |||||
| PENDLETON, Alan George | Administrateur | 12 Harrop Road Hale WA15 9BX Altrincham Cheshire | British | 30248370001 | ||||||
| PRICE, Anthony Hall | Administrateur | Irton CA19 1UZ Holmrook Mecklin Cumbria | England | British | 134973860001 | |||||
| SHIPPEN, Kenneth | Administrateur | 14 Rectory Park NE61 2SZ Morpeth Northumberland | British | 67917400001 | ||||||
| SHUTTLEWORTH, Richard Peter | Administrateur | c/o C/O Redhall Group Plc Red Hall Court WF1 2UN Wakefield 1 West Yorkshire England | England | British | 58727820002 | |||||
| TAYLOR, William Platt | Administrateur | Ryton House Mainsforth DL17 9AA Ferryhill County Durham | British | 7203810001 | ||||||
| WARDLE, Peter | Administrateur | 14 Brandling Park Jesmond NE2 4RR Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 73518260002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHIEFTAIN GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redhall Group Plc | 06 avr. 2016 | Calder Close Durkar WF4 3BA Wakefield Unit 3 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CHIEFTAIN GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 24 janv. 2019 Livré le 29 janv. 2019 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 24 janv. 2019 Livré le 29 janv. 2019 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 24 déc. 2015 Livré le 02 janv. 2016 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 janv. 2011 Livré le 28 janv. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 avr. 2009 Livré le 09 mai 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 28 mai 2004 Livré le 17 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattel mortgage | Créé le 09 sept. 1996 Livré le 12 sept. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Dean smith & grace model 20SB surfacing and boring lathe 29IN swing serial no 28803 richards model PR2N horizontal facing and boring machine serial no 28803 atlas copco model GA708 packaged rotary screw air compressor serial no 753329 and 753330 for further details please see form 395. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 01 août 1996 Livré le 13 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Premises at bath street walker newcastle upon tyne tyne and wear t/no:- ty 7137. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 02 nov. 1994 Livré le 11 nov. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 26 août 1992 Livré le 09 sept. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See doc ref M593C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 20 janv. 1988 Livré le 05 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 03 juin 1985 Livré le 11 juin 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that land at arrow close, killingwood north tyneside, tyne & wear with the factory premises t/n ty 157748. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 21 sept. 1984 Livré le 28 sept. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or sheaffer fabrications limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0