BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01457020 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o MOTIVCOM PLC Avalon House Breckland Linford Wood MK14 6LD Milton Keynes Buckinghamshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
État du capital au 08 oct. 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Sebastien Raymond De Tramasure en tant qu'administrateur le 21 nov. 2014 | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Sebastien Desire Paul Godet en tant qu'administrateur le 21 nov. 2014 | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de David Christopher Lebond en tant que directeur le 21 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de John Murray Sylvester en tant que directeur le 21 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Phillip Cooper en tant que directeur le 20 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Phillip Cooper le 27 mai 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Rockingham Drive Linford Wood Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6LY* le 21 mars 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOCKEN, Susan Ann | Secrétaire | 7 The Knoll Ealing W13 8HZ London | British | 9833560001 | ||||||
DE TRAMASURE, Sebastien Raymond | Administrateur | c/o Motivcom Plc Breckland Linford Wood MK14 6LD Milton Keynes Avalon House Buckinghamshire | France | French | Chief Finacial Officer | 172688760001 | ||||
GODET, Sebastien Desire Paul | Administrateur | c/o Motivcom Plc Breckland Linford Wood MK14 6LD Milton Keynes Avalon House Buckinghamshire | France | French | Gift Market Ceo | 193534940001 | ||||
HOCKEN, Susan Ann | Administrateur | 7 The Knoll Ealing W13 8HZ London | England | British | Chartered Accountant | 9833560001 | ||||
ARMSTRONG, David Frank | Secrétaire | 2 Mayfield Close KT12 5PR Walton On Thames Surrey | British | 7390540001 | ||||||
BASHAM, David | Secrétaire | Garden Cottage The Green NN13 5JX Turweston Northamptonshire | British | Company Director | 83199820001 | |||||
ARMSTRONG, David Frank | Administrateur | 2 Mayfield Close KT12 5PR Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | Travel Executive | 7390540001 | ||||
BASHAM, David | Administrateur | Garden Cottage The Green NN13 5JX Turweston Northamptonshire | British | Company Director | 83199820001 | |||||
BRENCHLEY, William Ian | Administrateur | Manor House Farm Beckerings Park Lidlington MK43 0RA Bedford | British | Travel Executive | 7390550001 | |||||
COOPER, Nigel Phillip | Administrateur | c/o Motivcom Plc Breckland Linford Wood MK14 6LD Milton Keynes Avalon House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 241240690001 | ||||
FISHER, John | Administrateur | 8 The Chestnuts Radley Road OX14 3YN Abingdon Oxfordshire | British | Marketing | 75380310001 | |||||
LEBOND, David Christopher | Administrateur | The Oaks 2 Noah's Court Gardens SG138FD Hertford Hertfordshire | England | British | Managing Director | 59555260003 | ||||
MOY, Anthony Gibson | Administrateur | The Grange Dingley Road Great Bowden LE16 7ET Market Harborough Leicestershire | United Kingdom | British | Company Director | 62053990001 | ||||
SYLVESTER, John Murray | Administrateur | Barnett House Barnett Way Bierton HP22 5DN Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 58011420002 | ||||
THOMAS, Diane Margaret | Administrateur | 32 Cotney Croft SG2 9PT Stevenage Hertfordshire | British | Accountant | 57501550001 | |||||
THOMAS, Diane Margaret | Administrateur | 32 Cotney Croft SG2 9PT Stevenage Hertfordshire | British | Accountant | 57501550001 | |||||
TULLETT, Andrew John | Administrateur | Twin Oaks Buckland Common PH23 6NQ Tring Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 111975800001 |
BREVIS MARKETING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 17 avr. 2003 Livré le 25 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 22 avr. 1998 Livré le 25 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 oct. 1996 Livré le 22 oct. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 août 1993 Livré le 06 sept. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H-239 st albans road watford hertfordshire together with all fixtures and fittings and the benefits of all rights licences and goodwill. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 03 févr. 1986 Livré le 17 févr. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding sterling pounds 40000 | |
Brèves mentions All moneys neweratanry time hereqbtes standing to the credit of any account (5) of the company with the bouls desingnated barclays bauls PLC re breins marketing services limited. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 20 août 1981 Livré le 26 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H 178 st albans road watford herts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0