PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01458009 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 07 déc. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Virginia Warr en tant que directeur le 03 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Bergin en tant que directeur le 03 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant que directeur le 03 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles John Middleton en tant que directeur le 31 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Virginia Warr en tant qu'administrateur le 18 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruce Michael James en tant que directeur le 31 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Gavin Bergin en tant qu'administrateur le 29 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nick Taunt en tant qu'administrateur le 05 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tom Robson en tant que directeur le 11 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Josephine Hayman en tant qu'administrateur le 31 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Tom Robson en tant qu'administrateur le 31 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| HAYMAN, Josephine | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 266797860001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| CLIFTON, Sally Jane | Secrétaire | Braeside Old Micheldever Road SP11 7AF Longparish Hampshire | British | 77925190001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Secrétaire | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| LAWLEY, Anne Katharine | Secrétaire | 25 Parkside 17 Hamilton Road Ealing W5 2EG London | British | 39298940001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secrétaire | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Secrétaire | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
| STOKES, Martin Howard | Secrétaire | 1 Hazel Grove SO22 4PQ Winchester Hampshire | British | 7345750001 | ||||||||||
| AYRE, Timothy Andrew | Administrateur | 14 Ridgmont Road AL1 3AF St Albans Hertfordshire | British | 1440830002 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BERGIN, Gavin Joseph | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 251327820001 | |||||||||
| BLUNDELL, Roger Frederick Crawford | Administrateur | Vineyard Hill Road SW19 7JL London 61 | England | British | 56525730002 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Administrateur | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BURGESS, Richard John | Administrateur | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||||||
| CARTER, Colin James | Administrateur | 6 Hawthorn Close Firtree Road SM7 1ND Banstead Surrey | British | 39118310002 | ||||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Administrateur | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Administrateur | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| COLEMAN, David Michael | Administrateur | Downings 18 Uplands Way Riverhead TN13 3BW Sevenoaks Kent | British | 2305220001 | ||||||||||
| CREEDY, Mark Peter | Administrateur | 18 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11841300002 | |||||||||
| CUTT, Michael Caslake | Administrateur | Cedar House Coombe Lane Sunninghill SL5 7AT Ascot Berkshire | British | 72423090001 | ||||||||||
| ELLIOTT, Mark Steven | Administrateur | 1 Elmwood AL8 6LD Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 59140240001 | |||||||||
| FLEMING, Keith | Administrateur | Dairy Cottage, Church Barns Church Bank Road, East Stratton SO21 3XA Winchester Hampshire | British | 96487450002 | ||||||||||
| GARDEN, Ian Graham | Administrateur | 10 Prairie Street SW8 3PU London | British | 64361460001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HARTWELL, Terrance | Administrateur | Brambledene 231 Winchester Road SO53 2DX Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | 147043140001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Administrateur | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| JONES, Alan Arnold | Administrateur | Laurel Cottages Pump Meadow HP16 9EW Great Missenden Buckinghamshire | British | 1440820003 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Administrateur | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LIGHT, Arthur Nicolas | Administrateur | 88 Peperharow Road GU7 2PN Godalming Surrey | British | 851100001 | ||||||||||
| LINDSAY, Niall Gordon Brock | Administrateur | Flat 4 8 Edge Hill SW19 4LP London | British | 62950250002 | ||||||||||
| MARSH, John Charles | Administrateur | 25 Cambridge Street TN2 4SJ Tunbridge Wells Kent | British | 59140360001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Sunrise Limited | 06 avr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
PROJECT SUNRISE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security deposit deed | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 31 juil. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement dated 7 july 1995 | |
Brèves mentions £174,526.03. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed legal charge | Créé le 20 juin 1994 Livré le 21 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the principal agreement and under the terms of the legal charge | |
Brèves mentions F/H-17, 18 and 19 northbrook street newbury berkshire t/n-BK55827. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 déc. 1988 Livré le 11 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti Sterling pounds 2000000 and all monies due or to be come due from the company and/or portswood developments limited to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88 | |
Brèves mentions Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901 (part) title no k 476373 (whole). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 déc. 1988 Livré le 11 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti Sterling pounds 1500000 and all other monies due or to be come due from the company to the chargee under the terms of an option agreement dated 23.12.88 | |
Brèves mentions Land and buildings on the south side of bridge street dover kent title no k 621901. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 14 nov. 1986 Livré le 25 nov. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Various subjects shown on the form 395 refer for details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0