OAKDALE BAKERIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOAKDALE BAKERIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01461281
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OAKDALE BAKERIES LIMITED ?

    • (1581) /

    Où se situe OAKDALE BAKERIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OAKDALE BAKERIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JOLLY BAKER LIMITED(THE)15 nov. 197915 nov. 1979

    Quels sont les derniers comptes de OAKDALE BAKERIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2005

    Quels sont les derniers dépôts pour OAKDALE BAKERIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 févr. 2011

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    4 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 juil. 2010

    8 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    4 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 janv. 2010

    8 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 juil. 2009

    6 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    19 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 25 juil. 2008

    22 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pages2.24B

    Déclaration des affaires

    12 pages2.16B

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    38 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    20 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de OAKDALE BAKERIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEVLIN, Paul John
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    Secrétaire
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    BritishDirector113889280001
    DEVLIN, Paul John
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    Administrateur
    3 Hall Close,
    Wheldrake
    YO19 6GB York
    N Yorks
    United KingdomBritishDirector113889280001
    HOLEBROOK, Maureen
    22, Chestnut Avenue
    Crosby
    L23 2SZ Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    22, Chestnut Avenue
    Crosby
    L23 2SZ Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishDirector113892420001
    KINGSLEY, Desmond Anthony
    Middleton House
    2 Redmayne Square
    YO32 5YN Strensal
    North Yorkshire
    Administrateur
    Middleton House
    2 Redmayne Square
    YO32 5YN Strensal
    North Yorkshire
    BritishDirector99683290001
    CAPEL, Lesley
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    British10077150001
    SAVILLE, Selwyn Michael
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant47615480001
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Administrateur
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector93024670001
    CAPEL, Lesley
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    10 St Andrews Croft
    LS17 7TP Leeds
    West Yorkshire
    BritishBaker10077150001
    CAPEL, Marshall Philip, Mr.
    Birkby Grange Farm
    Carr Lane Thorner
    LS14 3HG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Birkby Grange Farm
    Carr Lane Thorner
    LS14 3HG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishBaker154919490001
    DICKINSON, Michael John
    Woodsome House Woodsome Park
    Fenay Bridge
    HD8 0JG Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodsome House Woodsome Park
    Fenay Bridge
    HD8 0JG Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishDirector10819590001
    FREW, Robert Alexander
    Crayke Hall
    Church Hill, Crayke
    YO61 4TA York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Crayke Hall
    Church Hill, Crayke
    YO61 4TA York
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector71199280001
    GARDNER, Barrie Howard
    Roe Lodge
    Sowerby Row,Southwaite
    CA4 0QH Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Roe Lodge
    Sowerby Row,Southwaite
    CA4 0QH Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritishDirector80605980001
    LEE, Ian Edwin
    6 Brookhill Grove
    LS17 8QF Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Brookhill Grove
    LS17 8QF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector99683250001
    PAUL, Gilson
    Clarendon House
    38 Greenstile Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Humberside
    Administrateur
    Clarendon House
    38 Greenstile Lane
    HU14 3NH Swanland
    North Humberside
    BritishDirector104511560001
    SAVILLE, Selwyn Michael
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    476 Street Lane
    LS17 6HA Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant47615480001
    YOUNG, Janette
    7 Parc Mont
    9 Park Avenue
    LS8 2WE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Parc Mont
    9 Park Avenue
    LS8 2WE Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector112348660001

    OAKDALE BAKERIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 août 2004
    Livré le 24 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at ogden road shaw lane industrial estate doncaster t/no SYK213585, land at ogden road shaw lane industrial estate doncaster t/no SYK226329, f/h land at cole lane new springs aspull greater manchester t/no GM619850. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Islandsbanki Hf., as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties(Thesecurity Agent)
    Transactions
    • 24 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 2004
    Livré le 24 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit BT500/1 ogden road shaw lane industrial estate doncaster.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 03 oct. 2003
    Livré le 18 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings shortly known as 500/512 ogden road, shaw lane industrial estate, doncaster t/n SYK226329.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 03 oct. 2003
    Livré le 18 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings shortly known as bakery and offices at cale lane, aspull, wigan, greater manchester t/n GM619850.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 30 sept. 2003
    Livré le 02 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 02 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 10 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at cale lane wigan lancashire t/no: GM619850. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 08 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    £500,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The items as listed on the schedule attached. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 03 oct. 2002
    Livré le 03 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule :- intel piv-2GHZ midi tower with 15" svga monitor, compaq ML370 piii-1.4 Ghz dual processor & raid, controller (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 03 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2000
    Livré le 11 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 05 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 05 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 août 1997
    Livré le 05 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under the agreement or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge:-(i) all receivables including their related rights (as both terms are defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement.(ii) all amounts of indebtedness including their related rights now or at any time hereafter owing or becoming due to the company.floating charge such monies as the company may from time to time receive in respect of the other trade debts as shall from time to time stand released from the fixed charge thereon.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 19 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things as specified in form 395 relative to this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 19 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 août 1995
    Livré le 01 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the north east side of shaw lane, doncaster, south yorkshire t/no: SYK226329. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 01 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 12 mai 1995
    Livré le 16 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 1995
    Livré le 04 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises situate on the north east side of shaw lane doncaster. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 10 oct. 1990
    Livré le 31 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture dated 3.11.86
    Brèves mentions
    All right title and interest arising out of a receivables financing agreement dated 7.6.90 and all book debts and other debts the subject of the charged agreements.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juin 1990
    Livré le 08 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a discounting agreement dated 7.6.90
    Brèves mentions
    All the book and other debts due to the company by way of a first fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 08 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 31 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 1988
    Livré le 18 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on the north east side of ogden road shaw lane industrial estate doncaster S. yorkshire T.N. syk 190933.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 27 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 nov. 1986
    Livré le 13 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold plot of land situate off thorn road, doncaster, south yorkshire which forms part of the english industrial estate corporation shaw lane industrial estate.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 nov. 1986
    Livré le 12 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or marshalls bakery limited on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge registered pursuant to an order of court dated 2 feb 1984.
    Créé le 01 juil. 1983
    Livré le 22 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 2 march 1984
    Brèves mentions
    L/H factory and land known as site number bt 500/12 shaw lane industrial estate doncaster, south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • The English Industrial Estates Corporation
    Transactions
    • 22 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OAKDALE BAKERIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 janv. 2007Administration started
    28 juil. 2008Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Myles Anthony Halley
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DateType
    28 juil. 2008Commencement of winding up
    02 juin 2011Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Myles Anthony Halley
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    Neville Street
    Leeds Ls14dw
    Mark Granville Firmin
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0