TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED

TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01461944
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAYLOR WOODROW CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED23 juin 199223 juin 1992

    Quels sont les derniers comptes de TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR le 01 mai 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mars 2014

    État du capital au 28 mars 2014

    • Capital: GBP 15,000,000
    SH01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Ryan Dirk Mangold en tant que directeur le 14 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Alex David Green en tant qu'administrateur le 14 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ryan Dirk Mangold le 28 mars 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Michael Andrew Lonnon le 28 mars 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Colin Richard Clapham le 28 mars 2011

    2 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 80 New Bond Street London W1S 1SB United Kingdom le 30 mars 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 2 Piries Place Horsham West Sussex RH12 1EH England

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Andrew Lonnon le 11 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Colin Richard Clapham le 11 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ryan Dirk Mangold le 23 sept. 2009

    1 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Other135438270002
    GREEN, Alex David
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director163779880001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary34521340004
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secrétaire
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    DE FEO, Caterina
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    British58246930001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secrétaire
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    KNOTT, Clifford Robin
    6 Pondwick Road
    AL5 2HG Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Pondwick Road
    AL5 2HG Harpenden
    Hertfordshire
    British4733640001
    ANDREW, Peter Robert
    Restronguet Passage
    Mylor Bridge
    TR11 5SS Falmouth
    Morningstar Cottage
    Cornwall
    Administrateur
    Restronguet Passage
    Mylor Bridge
    TR11 5SS Falmouth
    Morningstar Cottage
    Cornwall
    United KingdomBritishRegional Managing Director113503830002
    BROOKS, John Howard
    Arcadian Farnborough Hill
    BR6 7EQ Orpington
    Kent
    Administrateur
    Arcadian Farnborough Hill
    BR6 7EQ Orpington
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant34160470002
    CARNEY, Christopher
    5 Ruxley Ridge
    KT10 0HZ Claygate
    Surrey
    Administrateur
    5 Ruxley Ridge
    KT10 0HZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    EGERTON, Keith Robert
    The White House Run Common
    Shamley Green
    GU5 0SY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The White House Run Common
    Shamley Green
    GU5 0SY Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector/Surveyor4772680001
    GOODENOUGH, Stephen David
    46 Shorrolds Road
    Fulham
    SW6 7TP London
    Administrateur
    46 Shorrolds Road
    Fulham
    SW6 7TP London
    BritishChartered Surveyor34081100002
    HENDERSON, James Douglas
    15 Crossways
    Shenfield
    CM15 8QX Brentwood
    Essex
    Administrateur
    15 Crossways
    Shenfield
    CM15 8QX Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishDevelopment Surveyor67904180002
    HUNTINGTON, Neil
    Eastfield Cottage Eastfield Lane
    Whitchurch On Thames
    RG8 7EJ Reading
    Oxfordshire
    Administrateur
    Eastfield Cottage Eastfield Lane
    Whitchurch On Thames
    RG8 7EJ Reading
    Oxfordshire
    BritishDevelopment Surveyor35918950002
    KNOTT, Clifford Robin
    6 Pondwick Road
    AL5 2HG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Pondwick Road
    AL5 2HG Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary4733640001
    MANGOLD, Ryan Dirk
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomSouth African And BritishGroup Financial Controller138927020003
    PARKER, Guy Trevor
    Cann Lane North
    Woodside Mews
    WA4 5NF Appleton Warrington
    Caxton House
    Administrateur
    Cann Lane North
    Woodside Mews
    WA4 5NF Appleton Warrington
    Caxton House
    EnglandBritishChartered Surveyor130108080001
    TAYLOR, Roger
    23 Belvedere House
    Churchfields Avenue
    KT13 9XY Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    23 Belvedere House
    Churchfields Avenue
    KT13 9XY Weybridge
    Surrey
    BritishChartered Surveyor37718820002
    TAYLOR, Roger
    98 Waxwell Lane
    HA5 3ES Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    98 Waxwell Lane
    HA5 3ES Pinner
    Middlesex
    BritishChartered Surveyor37718820001
    THOMAS, Trevor Wilkinson
    The Old Stables
    Long Wittenham Road, North Moreton
    OX11 9AZ Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Old Stables
    Long Wittenham Road, North Moreton
    OX11 9AZ Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector6086750002
    WILBY, Anthony
    The Waveney
    15 Leighton Road
    CH64 3SF Neston
    South Wirral
    Administrateur
    The Waveney
    15 Leighton Road
    CH64 3SF Neston
    South Wirral
    BritishOperations Director, North93928430001

    TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 22 déc. 1993
    Livré le 06 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company and/or taylor woodrow PLC to the chargee in respect of a revolving multicurrency facility agreement dated 7TH april 1993 as amended and supplemented by an agreement dated 9TH september 1993
    Brèves mentions
    L/H property k/a the cascades shopping centre portsmouth tog: with all b uildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Den Danske Bank Aktieselskab
    Transactions
    • 06 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 10 juin 1982
    Livré le 24 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £500 due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 30/3/82
    Brèves mentions
    Floating charge over all its. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Taylor Woodrow Property Company Limited
    Transactions
    • 24 juin 1982Enregistrement d'une charge
    • 29 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TAYLOR WIMPEY CHIPPINDALE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 févr. 2015Dissolved on
    15 avr. 2014Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0